EDIFICIOS FUENTEMAR 16 18 SA
Cambio de denominación social
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Nombramiento: 26/02/2019 | ABANTE ASESORES GESTION SGIIC SA |
Presidente gestor |
| Nombramiento: 26/02/2019 | MUÑOZ ROJAS ENTRECANALES TERESA |
Representante |
| Nombramiento: 26/02/2019 | TEINLU INVERSIONES SL |
Consejero |
| Nombramiento: 26/02/2019 | TEINLU INVERSIONES SL |
Presidente |
| Nombramiento: 26/02/2019 | PACAMURO SL |
Consejero |
| Nombramiento: 26/02/2019 | CAMUROEN SL |
Consejero |
| Nombramiento: 26/02/2019 | INVERSIONES MUROCA SL |
Consejero |
| Nombramiento: 26/02/2019 | CAMUROEN SL |
Consejero delegado solidario |
| Nombramiento: 26/02/2019 | PACAMURO SL |
Consejero delegado solidario |
| Nombramiento: 26/02/2019 | MUÑOZ-ROJAS ENTRECANALES PABLO |
Representante |
| Nombramiento: 26/02/2019 | MUÑOZ ROJAS ENTRECANALES LUIS |
Representante |
| Nombramiento: 26/02/2019 | MUÑOZ ROJAS ENTRECANALES CARLOS |
Secretario |
| Nombramiento: 26/02/2019 | MUÑOZ ROJAS ENTRECANALES CARLOS |
Representante |
| Nombramiento: 05/12/2014 | MOORE STEPHENS IBERGRUP SAP |
Auditor |
| Nombramiento: 14/01/2014 | PUIGSERVER SACARESA JUAN |
Apoderado |
| Cese: 14/01/2014 | GUSTAFSSON BERNT GUNNAR |
Apoderado |
| Cese: 02/12/2013 | TEINLU INVERSIONES SL |
Consejero delegado solidario |
| Nombramiento: 02/12/2013 | PACAMURO SL |
Consejero delegado solidario |
| Nombramiento: 02/12/2013 | TEINLU INVERSIONES SL |
Consejero |
| Nombramiento: 02/12/2013 | TEINLU INVERSIONES SL |
Presidente |
| Nombramiento: 02/12/2013 | PACAMURO SL |
Consejero |
| Nombramiento: 02/12/2013 | CAMUROEN SL |
Consejero |
| Nombramiento: 02/12/2013 | INVERSIONES MUROCA SL |
Consejero |
| Nombramiento: 02/12/2013 | CAMUROEN SL |
Consejero delegado solidario |
| Nombramiento: 02/12/2013 | MUÑOZ ROJAS ENTRECANALES TERESA |
Representante |
| Nombramiento: 02/12/2013 | MUÑOZ ROJAS ENTRECANALES LUIS |
Representante |
| Nombramiento: 02/12/2013 | MUÑOZ ROJAS ENTRECANALES CARLOS |
Representante |
| Nombramiento: 02/12/2013 | MUÑOZ-ROJAS ENTRECANALES PABLO |
Representante |
| Nombramiento: 02/12/2013 | MUÑOZ ROJAS ENTRECANALES CARLOS |
Secretario |
| Nombramiento: 27/06/2013 | PUIGSERVER SACARES JUAN |
Apoderado |
| Cese: 27/12/2012 | SANCHEZ MALDONADO PEDRO |
Apoderado |
| Nombramiento: 17/07/2012 | SANCHEZ MALDONADO PEDRO |
Apoderado |
| Cese: 22/02/2012 | BDO AUDITORES SL |
Auditor |
| Nombramiento: 22/02/2012 | MOORE STEPHENS IBERGRUP SAP |
Auditor |
| Nombramiento: 20/02/2012 | PADIAL RAMIREZ ANTONIO |
Apoderado |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por EDIFICIOS FUENTEMAR 16 18 SA
26/02/2019 Detalles del anuncio (90198) Datos registrales: T 32477 , F 119, S 8, H M 172939, I/A 31 (19.02.19).
- Nombramientos
PRESI.GEST.: ABANTE ASESORES GESTION SGIIC SA.
- Reelecciones
Representan: MUÑOZ ROJAS ENTRECANALES TERESA. Consejero: TEINLU INVERSIONES SL. Presidente: TEINLU INVERSIONES SL. Consejero: PACAMURO SL;CAMUROEN SL;INVERSIONES MUROCA SL. Cons.Del.Sol: CAMUROEN SL;PACAMURO SL. Representan: MUÑOZ-ROJAS ENTRECANALES PABLO;MUÑOZ ROJAS ENTRECANALES LUIS. Secretario: MUÑOZ ROJAS ENTRECANALES CARLOS. Representan: MUÑOZ ROJAS ENTRECANALES CARLOS.
- Modificaciones Estatutarias
1. Nuevo texto de los Estatutos para su adaptación a la normativa de entidades de capital-riesgo.
- Cambio de denominación social
METIS CAPITAL SCR SA.
- Cambio de domicilio social
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 6 (MADRID).
- Página web de la sociedad
Creación de la página web corporativa: www.abanteasesores.com.
05/12/2014 Detalles del anuncio (498114) Datos registrales: T 32477 , F 119, S 8, H M 172939, I/A 30 (27.11.14).
- Reelecciones
Auditor: MOORE STEPHENS IBERGRUP SAP.
14/01/2014 Detalles del anuncio (12214) Datos registrales: T 10961 , F 214, S 8, H M 172939, I/A 28 ( 7.01.14).
- Nombramientos
Apoderado: PUIGSERVER SACARESA JUAN.
14/01/2014 Detalles del anuncio (12215) Datos registrales: T 10961 , F 215, S 8, H M 172939, I/A 29 ( 7.01.14).
- Revocaciones
Apoderado: GUSTAFSSON BERNT GUNNAR.
02/12/2013 Detalles del anuncio (513299) Datos registrales: T 10961 , F 213, S 8, H M 172939, I/A 27 (22.11.13).
- Ceses/Dimisiones
Cons.Del.Sol: TEINLU INVERSIONES SL.
- Nombramientos
Cons.Del.Sol: PACAMURO SL.
- Reelecciones
Consejero: TEINLU INVERSIONES SL. Presidente: TEINLU INVERSIONES SL. Consejero: PACAMURO SL;CAMUROEN SL;INVERSIONES MUROCA SL. Cons.Del.Sol: CAMUROEN SL. Representan: MUÑOZ ROJAS ENTRECANALES TERESA;MUÑOZ ROJAS ENTRECANALES LUIS;MUÑOZ ROJAS ENTRECANALES CARLOS;MUÑOZ-ROJAS ENTRECANALES PABLO. Secretario: MUÑOZ ROJAS ENTRECANALES CARLOS.
29/10/2013 Detalles del anuncio (462340) Datos registrales: T 10961 , F 213, S 8, H M 172939, I/A 26 (18.10.13).
- Ampliación de Capital
Suscrito: 1.277.076,92 Euros. Desembolsado: 1.277.076,92 Euros. Resultante Suscrito: 2.728.948,68 Euros. Resultante Desembolsado: 2.728.948,68 Euros.
27/06/2013 Detalles del anuncio (294273) Datos registrales: T 10961 , F 212, S 8, H M 172939, I/A 25 (20.06.13).
- Nombramientos
Apoderado: PUIGSERVER SACARES JUAN.
24/04/2013 Detalles del anuncio (192674) Datos registrales: T 10961 , F 212, S 8, H M 172939, I/A 24 (15.04.13).
- Reducción de Capital
Importe reducción: 53.933,74 Euros. Resultante Suscrito: 951.887,84 Euros.
- Ampliación de Capital
Suscrito: 499.983,92 Euros. Desembolsado: 499.983,92 Euros. Resultante Suscrito: 1.451.871,76 Euros. Resultante Desembolsado: 1.451.871,76 Euros.
- Modificaciones Estatutarias
Artículo de los estatutos: 5º. Capital.-.
27/12/2012 Detalles del anuncio (540071) Datos registrales: T 10961 , F 211, S 8, H M 172939, I/A 23 (19.12.12).
- Revocaciones
Apoderado: SANCHEZ MALDONADO PEDRO.
17/07/2012 Detalles del anuncio (300856) Datos registrales: T 10961 , F 211, S 8, H M 172939, I/A 22 ( 5.07.12).
- Nombramientos
Apoderado: SANCHEZ MALDONADO PEDRO.
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 20
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2019-39-28 | 26/02/2019 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2014-233-28 | 05/12/2014 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2014-8-28 | 14/01/2014 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2014-8-28 | 14/01/2014 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2013-230-28 | 02/12/2013 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2013-207-28 | 29/10/2013 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2013-120-28 | 27/06/2013 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2013-77-28 | 24/04/2013 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2012-247-28 | 27/12/2012 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2012-135-28 | 17/07/2012 | Madrid | Descargar |