DMR COMITE PERMANENTE SL

Activa

AVDA MANOTERAS 52 (MADRID).
Madrid
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 13/02/2020

FRANCES PONS FERNANDO JOSE

Consejero
Cese: 13/02/2020

FRANCES PONS FERNANDO JOSE

Presidente
Cese: 13/02/2020

FRANCES PONS FERNANDO JOSE

Consejero delegado solidario
Cese: 12/11/2014

EUSEBIO FERNANDEZ FERNANDO

Consejero
Nombramiento: 12/11/2014

ABRIL VERRAT BRUNO

Consejero
Cese: 22/01/2013

LOPEZ LUQUE FRANCISCO

Consejero
Cese: 22/01/2013

CHAO DE LA CRUZ MARIO LUIS

Consejero
Nombramiento: 22/01/2013

YAÑEZ RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO

Consejero
Nombramiento: 22/01/2013

REDONET SANCHEZ DEL CAMPO LUIS EUGENIO

Consejero
Cese: 23/10/2012

GRAS MAYMI MARTA

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 09/02/2012

BIOSCA ARPA SERGI

Consejero
Nombramiento: 09/02/2012

CHAO DE LA CRUZ MARIO LUIS

Consejero
Cese: 08/11/2011

ARECHABALETA GIL GORKA

Apoderado solidario
Nombramiento: 08/11/2011

CASTILLO GARCIA EMILIO

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 08/11/2011

GRAS MAYMI MARTA

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 08/11/2011

GOMEZ JARILLO ANTONIO

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 08/11/2011

TURON GINE ESTEVE

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 30/12/2009

VAZQUEZ BLANCO BENITO

Consejero delegado
Cese: 30/12/2009

GARRIDO ARRIBAS CARLOS ALBERTO

Consejero
Cese: 30/12/2009

GARRIDO ARRIBAS CARLOS ALBERTO

Consejero delegado solidario
Cese: 30/12/2009

CASABLANCAS SEGURA PERE

Consejero
Cese: 30/12/2009

ARECHABALA ANAYA JUAN

Consejero
Nombramiento: 30/12/2009

MEDINA MENDEZ GREGORIO

Consejero
Nombramiento: 30/12/2009

MARTINEZ DEL CAMPO CARLOS

Consejero
Nombramiento: 30/12/2009

BIOSCA ARPA SERGI

Consejero
Nombramiento: 09/12/2009

CASTILLO GARCIA EMILIO

Apoderado solidario
Nombramiento: 09/12/2009

ARECHABALETA GIL GORKA

Apoderado solidario
Cese: 19/01/2009

MEDINA MENDEZ GREGORIO

Consejero
Cese: 19/01/2009

ACITORES PEÑAFIEL SATURNINO

Consejero
Nombramiento: 19/01/2009

CASABLANCAS SEGURA PERE

Consejero
Nombramiento: 19/01/2009

ARECHABALA ANAYA JUAN

Consejero

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por DMR COMITE PERMANENTE SL

13/02/2020 Detalles del anuncio (67575) Datos registrales: T 25084 , F 204, S 8, H M 327328, I/A 22 ( 6.02.20).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: FRANCES PONS FERNANDO JOSE. Presidente: FRANCES PONS FERNANDO JOSE. Cons.Del.Sol: FRANCES PONS FERNANDO JOSE.

12/11/2014 Detalles del anuncio (457977) Datos registrales: T 25084 , F 204, S 8, H M 327328, I/A 21 ( 3.11.14).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: EUSEBIO FERNANDEZ FERNANDO.

  • Nombramientos

    Consejero: ABRIL VERRAT BRUNO.

22/01/2013 Detalles del anuncio (31785) Datos registrales: T 25084 , F 204, S 8, H M 327328, I/A 20 (15.01.13).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: LOPEZ LUQUE FRANCISCO;CHAO DE LA CRUZ MARIO LUIS.

  • Nombramientos

    Consejero: YAÑEZ RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO;REDONET SANCHEZ DEL CAMPO LUIS EUGENIO.

23/10/2012 Detalles del anuncio (431492) Datos registrales: T 25084 , F 203, S 8, H M 327328, I/A 19 (11.10.12).

  • Revocaciones

    Apo.Man.Soli: GRAS MAYMI MARTA.

09/02/2012 Detalles del anuncio (66037) Datos registrales: T 25084 , F 203, S 8, H M 327328, I/A 18 (27.01.12).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: BIOSCA ARPA SERGI.

  • Nombramientos

    Consejero: CHAO DE LA CRUZ MARIO LUIS.

08/11/2011 Detalles del anuncio (444021) Datos registrales: T 25084 , F 203, S 8, H M 327328, I/A 17 (26.10.11).

  • Revocaciones

    Apo.Sol.: ARECHABALETA GIL GORKA.

  • Nombramientos

    Apo.Man.Soli: CASTILLO GARCIA EMILIO;GRAS MAYMI MARTA;GOMEZ JARILLO ANTONIO;TURON GINE ESTEVE.

25/10/2010 Detalles del anuncio (890646)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Octubre de 2010) Año: 2009

24/03/2010 Detalles del anuncio (121325) Datos registrales: T 25084 , F 202, S 8, H M 327328, I/A B (12.03.10).

  • Otros Conceptos

    CANCELACION DE LA ANOTACION PREVENTIVA DE DEMANDA ACORDADA POR AUTO DE FECHA 7 DE JULIO DE 2008.

11/01/2010 Detalles del anuncio (8436) Datos registrales: T 25084 , F 201, S 8, H M 327328, I/A 15 (23.12.09).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 1,23 Euros. Resultante Suscrito: 3.006,00 Euros.

  • Modificaciones Estatutarias

    4. Capital.-. 4. bis. Capital.-. 4.ter. Capital.-. 11. Acciones/Participaciones.-. 35. Aplicación del resultado. Distribución de dividendos .

30/12/2009 Detalles del anuncio (543266) Datos registrales: T 25084 , F 201, S 8, H M 327328, I/A 14 (18.12.09).

  • Nombramientos

    Con.Delegado: VAZQUEZ BLANCO BENITO.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 17

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2020-30-28 13/02/2020 Madrid Descargar
BORME-A-2014-216-28 12/11/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2013-14-28 22/01/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2012-204-28 23/10/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-28-28 09/02/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2011-212-28 08/11/2011 Madrid Descargar
BORME-B-2010-205-28 25/10/2010 Madrid Descargar
BORME-A-2010-56-28 24/03/2010 Madrid Descargar
BORME-A-2010-5-28 11/01/2010 Madrid Descargar
BORME-A-2009-248-28 30/12/2009 Madrid Descargar