DMR COMITE PERMANENTE SL
Activa
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Cese: 13/02/2020 | FRANCES PONS FERNANDO JOSE |
Consejero |
| Cese: 13/02/2020 | FRANCES PONS FERNANDO JOSE |
Presidente |
| Cese: 13/02/2020 | FRANCES PONS FERNANDO JOSE |
Consejero delegado solidario |
| Cese: 12/11/2014 | EUSEBIO FERNANDEZ FERNANDO |
Consejero |
| Nombramiento: 12/11/2014 | ABRIL VERRAT BRUNO |
Consejero |
| Cese: 22/01/2013 | LOPEZ LUQUE FRANCISCO |
Consejero |
| Cese: 22/01/2013 | CHAO DE LA CRUZ MARIO LUIS |
Consejero |
| Nombramiento: 22/01/2013 | YAÑEZ RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO |
Consejero |
| Nombramiento: 22/01/2013 | REDONET SANCHEZ DEL CAMPO LUIS EUGENIO |
Consejero |
| Cese: 23/10/2012 | GRAS MAYMI MARTA |
Apoderado mancomunado solidario |
| Cese: 09/02/2012 | BIOSCA ARPA SERGI |
Consejero |
| Nombramiento: 09/02/2012 | CHAO DE LA CRUZ MARIO LUIS |
Consejero |
| Cese: 08/11/2011 | ARECHABALETA GIL GORKA |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 08/11/2011 | CASTILLO GARCIA EMILIO |
Apoderado mancomunado solidario |
| Nombramiento: 08/11/2011 | GRAS MAYMI MARTA |
Apoderado mancomunado solidario |
| Nombramiento: 08/11/2011 | GOMEZ JARILLO ANTONIO |
Apoderado mancomunado solidario |
| Nombramiento: 08/11/2011 | TURON GINE ESTEVE |
Apoderado mancomunado solidario |
| Nombramiento: 30/12/2009 | VAZQUEZ BLANCO BENITO |
Consejero delegado |
| Cese: 30/12/2009 | GARRIDO ARRIBAS CARLOS ALBERTO |
Consejero |
| Cese: 30/12/2009 | GARRIDO ARRIBAS CARLOS ALBERTO |
Consejero delegado solidario |
| Cese: 30/12/2009 | CASABLANCAS SEGURA PERE |
Consejero |
| Cese: 30/12/2009 | ARECHABALA ANAYA JUAN |
Consejero |
| Nombramiento: 30/12/2009 | MEDINA MENDEZ GREGORIO |
Consejero |
| Nombramiento: 30/12/2009 | MARTINEZ DEL CAMPO CARLOS |
Consejero |
| Nombramiento: 30/12/2009 | BIOSCA ARPA SERGI |
Consejero |
| Nombramiento: 09/12/2009 | CASTILLO GARCIA EMILIO |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 09/12/2009 | ARECHABALETA GIL GORKA |
Apoderado solidario |
| Cese: 19/01/2009 | MEDINA MENDEZ GREGORIO |
Consejero |
| Cese: 19/01/2009 | ACITORES PEÑAFIEL SATURNINO |
Consejero |
| Nombramiento: 19/01/2009 | CASABLANCAS SEGURA PERE |
Consejero |
| Nombramiento: 19/01/2009 | ARECHABALA ANAYA JUAN |
Consejero |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por DMR COMITE PERMANENTE SL
13/02/2020 Detalles del anuncio (67575) Datos registrales: T 25084 , F 204, S 8, H M 327328, I/A 22 ( 6.02.20).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: FRANCES PONS FERNANDO JOSE. Presidente: FRANCES PONS FERNANDO JOSE. Cons.Del.Sol: FRANCES PONS FERNANDO JOSE.
12/11/2014 Detalles del anuncio (457977) Datos registrales: T 25084 , F 204, S 8, H M 327328, I/A 21 ( 3.11.14).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: EUSEBIO FERNANDEZ FERNANDO.
- Nombramientos
Consejero: ABRIL VERRAT BRUNO.
22/01/2013 Detalles del anuncio (31785) Datos registrales: T 25084 , F 204, S 8, H M 327328, I/A 20 (15.01.13).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: LOPEZ LUQUE FRANCISCO;CHAO DE LA CRUZ MARIO LUIS.
- Nombramientos
Consejero: YAÑEZ RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO;REDONET SANCHEZ DEL CAMPO LUIS EUGENIO.
23/10/2012 Detalles del anuncio (431492) Datos registrales: T 25084 , F 203, S 8, H M 327328, I/A 19 (11.10.12).
- Revocaciones
Apo.Man.Soli: GRAS MAYMI MARTA.
09/02/2012 Detalles del anuncio (66037) Datos registrales: T 25084 , F 203, S 8, H M 327328, I/A 18 (27.01.12).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: BIOSCA ARPA SERGI.
- Nombramientos
Consejero: CHAO DE LA CRUZ MARIO LUIS.
08/11/2011 Detalles del anuncio (444021) Datos registrales: T 25084 , F 203, S 8, H M 327328, I/A 17 (26.10.11).
- Revocaciones
Apo.Sol.: ARECHABALETA GIL GORKA.
- Nombramientos
Apo.Man.Soli: CASTILLO GARCIA EMILIO;GRAS MAYMI MARTA;GOMEZ JARILLO ANTONIO;TURON GINE ESTEVE.
25/10/2010 Detalles del anuncio (890646)
- Depósitos de cuentas anuales
(Octubre de 2010) Año: 2009
24/03/2010 Detalles del anuncio (121325) Datos registrales: T 25084 , F 202, S 8, H M 327328, I/A B (12.03.10).
- Otros Conceptos
CANCELACION DE LA ANOTACION PREVENTIVA DE DEMANDA ACORDADA POR AUTO DE FECHA 7 DE JULIO DE 2008.
11/01/2010 Detalles del anuncio (8436) Datos registrales: T 25084 , F 201, S 8, H M 327328, I/A 15 (23.12.09).
- Reducción de Capital
Importe reducción: 1,23 Euros. Resultante Suscrito: 3.006,00 Euros.
- Modificaciones Estatutarias
4. Capital.-. 4. bis. Capital.-. 4.ter. Capital.-. 11. Acciones/Participaciones.-. 35. Aplicación del resultado. Distribución de dividendos .
30/12/2009 Detalles del anuncio (543266) Datos registrales: T 25084 , F 201, S 8, H M 327328, I/A 14 (18.12.09).
- Nombramientos
Con.Delegado: VAZQUEZ BLANCO BENITO.
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 17
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2020-30-28 | 13/02/2020 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2014-216-28 | 12/11/2014 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2013-14-28 | 22/01/2013 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2012-204-28 | 23/10/2012 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2012-28-28 | 09/02/2012 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2011-212-28 | 08/11/2011 | Madrid | Descargar |
| BORME-B-2010-205-28 | 25/10/2010 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2010-56-28 | 24/03/2010 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2010-5-28 | 11/01/2010 | Madrid | Descargar |
| BORME-A-2009-248-28 | 30/12/2009 | Madrid | Descargar |