DIGAMEL SA

Extinta

LUGAR COSTADO, 5
Pontevedra  (36162)
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 25/06/2024

BORSOT FERNANDEZ EDUARDO

Apoderado
Nombramiento: 25/06/2024

RODRIGUEZ-MARQUES FENOLLERA NURIA

Apoderado
Cese: 06/03/2024

VERSPIEREN JEAN CYRILLE

Consejero
Cese: 06/03/2024

VERSPIEREN JEAN CYRILLE

Presidente
Nombramiento: 06/03/2024

GARCIA FLOREN BARBARA

Consejero
Nombramiento: 06/03/2024

GARCIA FLOREN BARBARA

Presidente
Nombramiento: 12/01/2024

MAZARS AUDITORES SLP

Auditor
Nombramiento: 16/11/2023

FANJUL SUAREZ MARCO

Apoderado solidario
Nombramiento: 16/11/2023

LEDESMA SANCHEZ GABRIEL

Apoderado solidario
Cese: 10/08/2023

DAMAPIMA SL

Administrador único
Nombramiento: 10/08/2023

VERSPIEREN JEAN CYRILLE

Consejero
Nombramiento: 10/08/2023

VERSPIEREN JEAN CYRILLE

Presidente
Nombramiento: 10/08/2023

ARROYO MARTOS JOSE

Consejero
Nombramiento: 10/08/2023

SONEPAR IBERICA SA

Consejero
Nombramiento: 10/08/2023

JIMENEZ ORTIZ ELENA

Secretario no consejero
Nombramiento: 10/08/2023

RODRIGUEZ-MARQUES FENOLLERA NURIA

Vicesecretario no consejero
Nombramiento: 10/08/2023

VERSPIEREN JEAN CYRILLE

Apoderado solidario
Nombramiento: 10/08/2023

ARROYO MARTOS JOSE

Apoderado solidario
Nombramiento: 27/12/2022

AUDITORIA INTERNACIONAL SLP

Auditor
Nombramiento: 04/03/2022

DAMAPIMA SL

Administrador único
Nombramiento: 21/12/2021

AUDITORIA INTERNACIONAL SLP

Auditor

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por DIGAMEL SA

16/12/2024 Detalles del anuncio (544587) Datos registrales: S 8 , H PO 1072, I/A 46 ( 9.12.24).

  • Disolución

    Fusion.

  • Extinción

25/06/2024 Detalles del anuncio (286431) Datos registrales: S 8 , H PO 1072, I/A 45 (18.06.24).

  • Nombramientos

    Apoderado: BORSOT FERNANDEZ EDUARDO.

25/06/2024 Detalles del anuncio (286430) Datos registrales: S 8 , H PO 1072, I/A 44 (18.06.24).

  • Nombramientos

    Apoderado: RODRIGUEZ-MARQUES FENOLLERA NURIA.

06/03/2024 Detalles del anuncio (116327) Datos registrales: T 914, L 914, F 174, S 8, H PO 1072, I/A 42 (28.02.24).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: VERSPIEREN JEAN CYRILLE. Presidente: VERSPIEREN JEAN CYRILLE.

  • Nombramientos

    Consejero: GARCIA FLOREN BARBARA. Presidente: GARCIA FLOREN BARBARA.

12/01/2024 Detalles del anuncio (18663) Datos registrales: T 914, L 914, F 174, S 8, H PO 1072, I/A 41 ( 5.01.24).

  • Nombramientos

    Auditor: MAZARS AUDITORES SLP.

16/11/2023 Detalles del anuncio (488534) Datos registrales: T 914, L 914, F 173, S 8, H PO 1072, I/A 40 ( 7.11.23).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: FANJUL SUAREZ MARCO;LEDESMA SANCHEZ GABRIEL.

10/08/2023 Detalles del anuncio (363519) Datos registrales: T 914, L 914, F 171, S 8, H PO 1072, I/A 38 ( 1.08.23).

  • Declaración de unipersonalidad. Socio Único.

    SONEPAR IBERICA SA.

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: DAMAPIMA SL.

  • Nombramientos

    Consejero: VERSPIEREN JEAN CYRILLE. Presidente: VERSPIEREN JEAN CYRILLE. Consejero: ARROYO MARTOS JOSE;SONEPAR IBERICA SA. SecreNoConsj: JIMENEZ ORTIZ ELENA. VsecrNoConsj: RODRIGUEZ-MARQUES FENOLLERA NURIA.

  • Otros Conceptos

    Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración. Modificación de los artículos 3, 7, 10, 12, 13, 14, 15 y 15 bis de los Estatutos Sociales.

10/08/2023 Detalles del anuncio (363520) Datos registrales: T 914, L 914, F 172, S 8, H PO 1072, I/A 39 ( 1.08.23).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: VERSPIEREN JEAN CYRILLE;ARROYO MARTOS JOSE.

27/12/2022 Detalles del anuncio (566436) Datos registrales: T 914, L 914, F 171, S 8, H PO 1072, I/A 37 (16.12.22).

  • Reelecciones

    Auditor: AUDITORIA INTERNACIONAL SLP.

04/03/2022 Detalles del anuncio (99076) Datos registrales: T 914, L 914, F 171, S 8, H PO 1072, I/A 36 (24.02.22).

  • Reelecciones

    Adm. Unico: DAMAPIMA SL.

  • Otros Conceptos

    Creación del artículo 12 bis de los Estatutos Sociales relativo al lugar de celebración de la junta y su asistencia por medios telemáticos.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 32

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2024-241-36 16/12/2024 Pontevedra Descargar
BORME-A-2024-121-36 25/06/2024 Pontevedra Descargar
BORME-A-2024-121-36 25/06/2024 Pontevedra Descargar
BORME-A-2024-47-36 06/03/2024 Pontevedra Descargar
BORME-A-2024-9-36 12/01/2024 Pontevedra Descargar
BORME-A-2023-218-36 16/11/2023 Pontevedra Descargar
BORME-A-2023-152-36 10/08/2023 Pontevedra Descargar
BORME-A-2023-152-36 10/08/2023 Pontevedra Descargar
BORME-A-2022-244-36 27/12/2022 Pontevedra Descargar
BORME-A-2022-44-36 04/03/2022 Pontevedra Descargar