DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS TEXTILES SL

Activa

CTRA NACIONAL SANTANDER A OVIEDO, S/N. ONTORIA. (CABEZON DE LA SAL).
 Cabezón de la Sal, Cantabria
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 24/06/2021

PARES BOJ CONRADO

Consejero
Nombramiento: 24/06/2021

PARES BOJ JUAN ANGEL

Consejero
Nombramiento: 24/06/2021

PARES BOJ ISAAC

Consejero
Nombramiento: 24/06/2021

PARES BOJ CONRADO

Presidente
Nombramiento: 24/06/2021

BENET SERRA GEMMA

Consejero
Nombramiento: 24/06/2021

PARES BOJ JUAN ANGEL

Secretario
Nombramiento: 24/06/2021

PARES BOJ JUAN ANGEL

Consejero delegado
Nombramiento: 06/11/2020

RODRIGUEZ FELIX GONZALO

Apoderado
Nombramiento: 10/09/2020

RODRIGUEZ FELIX GONZALO

Apoderado
Nombramiento: 05/09/2016

PARES BOJ CONRADO

Consejero
Nombramiento: 05/09/2016

PARES BOJ JUAN ANGEL

Consejero
Nombramiento: 05/09/2016

PARES BOJ ISAAC

Consejero
Nombramiento: 05/09/2016

PARES BOJ CONRADO

Presidente
Nombramiento: 05/09/2016

BENET SERRA GEMMA

Consejero
Nombramiento: 05/09/2016

PARES BOJ JUAN ANGEL

Secretario
Nombramiento: 05/09/2016

PARES BOJ JUAN ANGEL

Consejero delegado
Nombramiento: 13/03/2014

DESPATX I GABINET DAUDITORIA SL

Auditor
Cese: 16/04/2013

BENET CAMPS JORGE

Consejero
Cese: 16/04/2013

CADAHIA CASLA JOSE RAMON

Secretario no consejero
Cese: 16/04/2013

VAGAÑON SOLANAS BORJA

Vicesecretario no consejero
Cese: 16/04/2013

LLOPIS GARCIA ANTONIO

Apoderado
Nombramiento: 16/04/2013

BENET SERRA GEMMA

Consejero
Nombramiento: 16/04/2013

PARES BOJ JUAN ANGEL

Secretario
Nombramiento: 16/04/2013

PARES BOJ JUAN ANGEL

Consejero delegado
Cese: 10/08/2010

PARES BOJ JUAN ANGEL

Administrador único
Nombramiento: 10/08/2010

PARES BOJ CONRADO

Consejero
Nombramiento: 10/08/2010

PARES BOJ JUAN ANGEL

Consejero
Nombramiento: 10/08/2010

BENET CAMPS JORGE

Consejero
Nombramiento: 10/08/2010

PARES BOJ ISAAC

Consejero
Nombramiento: 10/08/2010

PARES BOJ CONRADO

Presidente
Nombramiento: 10/08/2010

CADAHIA CASLA JOSE RAMON

Secretario no consejero
Nombramiento: 10/08/2010

VAGAÑON SOLANAS BORJA

Vicesecretario no consejero
Nombramiento: 10/08/2010

SANCHEZ MARTINEZ PATRICIA

Apoderado
Nombramiento: 10/08/2010

LLOPIS GARCIA ANTONIO

Apoderado
Nombramiento: 19/04/2010

PARES BOJ JUAN ANGEL

Administrador único

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS TEXTILES SL

24/06/2021 Detalles del anuncio (307871) Datos registrales: T 1231 , F 136, S 8, H S 34664, I/A 5 (15.06.21).

  • Reelecciones

    Consejero: PARES BOJ CONRADO;PARES BOJ JUAN ANGEL;PARES BOJ ISAAC. Presidente: PARES BOJ CONRADO. Consejero: BENET SERRA GEMMA. Secretario: PARES BOJ JUAN ANGEL. Con.Delegado: PARES BOJ JUAN ANGEL.

06/11/2020 Detalles del anuncio (381076) Datos registrales: T 1231 , F 136, S 8, H S 34664, I/A 4 (28.10.20).

  • Nombramientos

    Apoderado: RODRIGUEZ FELIX GONZALO.

10/09/2020 Detalles del anuncio (304924) Datos registrales: T 1231 , F 135, S 8, H S 34664, I/A 3 (31.08.20).

  • Nombramientos

    Apoderado: RODRIGUEZ FELIX GONZALO.

10/09/2020 Detalles del anuncio (304923) Datos registrales: T 1231 , F 127, S 8, H S 34664, I/A 2 (31.08.20).

  • Cambio de domicilio social

    CTRA NACIONAL SANTANDER A OVIEDO, S/N. ONTORIA. (CABEZON DE LA SAL).

05/09/2016 Detalles del anuncio (364546) Datos registrales: T 27603 , F 88, S 8, H M 497435, I/A 8 (29.08.16).

  • Reelecciones

    Consejero: PARES BOJ CONRADO;PARES BOJ JUAN ANGEL;PARES BOJ ISAAC. Presidente: PARES BOJ CONRADO. Consejero: BENET SERRA GEMMA. Secretario: PARES BOJ JUAN ANGEL. Con.Delegado: PARES BOJ JUAN ANGEL.

13/03/2014 Detalles del anuncio (115315) Datos registrales: T 27603 , F 88, S 8, H M 497435, I/A 7 ( 5.03.14).

  • Nombramientos

    Auditor: DESPATX I GABINET DAUDITORIA SL.

26/09/2013 Detalles del anuncio (413790) Datos registrales: T 27603 , F 88, S 8, H M 497435, I/A 6 (18.09.13).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 1.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.160.601,00 Euros.

  • Otros Conceptos

    NUEVA REDACCION DEL ARTICULO 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

25/09/2013 Detalles del anuncio (411709) Datos registrales: T 27603 , F 87, S 8, H M 497435, I/A 5 (17.09.13).

  • Otros Conceptos

    SE SUBSANA LA ESCRITURA ORIGEN DE LA INSCRIPCION 4 EN CUANTO AL DOMICILIO SOCIAL, SIENDO EL CORRECTO: LA CALLE DE LOECHES, NAVE 58, 2-A Y C, ESQUINA LOS MOLINOS, POLIGONO INDUSTRIAL VENTORRO DEL CANO, ALCORCON, MADRID.

16/04/2013 Detalles del anuncio (178193) Datos registrales: T 27603 , F 86, S 8, H M 497435, I/A 4 ( 8.04.13).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: BENET CAMPS JORGE. SecreNoConsj: CADAHIA CASLA JOSE RAMON. VsecrNoConsj: VAGAÑON SOLANAS BORJA.

  • Revocaciones

    Apoderado: LLOPIS GARCIA ANTONIO.

  • Nombramientos

    Consejero: BENET SERRA GEMMA. Secretario: PARES BOJ JUAN ANGEL. Con.Delegado: PARES BOJ JUAN ANGEL.

  • Cambio de domicilio social

    C/ DE LOECHES, LOCAL N-58, 2-B - PARQUE EMPRESARI (ALCORCON).

15/04/2013 Detalles del anuncio (175839) Datos registrales: T 27603 , F 86, S 8, H M 497435, I/A 3 ( 8.04.13).

  • Otros Conceptos

    RECTIFICACION INSCRIPCION 2&.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 12

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2021-119-39 24/06/2021 Cantabria Descargar
BORME-A-2020-215-39 06/11/2020 Cantabria Descargar
BORME-A-2020-176-39 10/09/2020 Cantabria Descargar
BORME-A-2020-176-39 10/09/2020 Cantabria Descargar
BORME-A-2016-169-28 05/09/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2014-50-28 13/03/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2013-184-28 26/09/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-183-28 25/09/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-71-28 16/04/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-70-28 15/04/2013 Madrid Descargar