DEHESA DE LAS CABRERIZAS SL
Activa
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
Fecha
|
Nombre
|
|
---|---|---|
Cese: 25/02/2025 | DIAZ LOPEZ IÑIGO |
Apoderado |
Nombramiento: 25/02/2025 | DIAZ LOPEZ IÑIGO |
Apoderado |
Nombramiento: 16/02/2024 | AUDITORES Y CENSORES ASOCIADOS SL |
Auditor |
Cese: 03/08/2023 | DIAZ LOPEZ MARIA REYES |
Consejero |
Cese: 03/08/2023 | DIAZ LOPEZ CARLOS |
Consejero |
Cese: 03/08/2023 | DIAZ LOPEZ MARIA REYES |
Presidente |
Nombramiento: 03/08/2023 | DIAZ LOPEZ CARLOS LUIS |
Representante |
Nombramiento: 03/08/2023 | DIAZ LOPEZ MARIA REYES |
Representante |
Nombramiento: 03/08/2023 | ALDEBARAN CHARTERS SL |
Consejero |
Nombramiento: 03/08/2023 | SAESDI CONSULTING SL |
Consejero |
Nombramiento: 03/08/2023 | DIAZ LOPEZ IÑIGO |
Presidente |
Nombramiento: 03/08/2023 | DIAZ LOPEZ MARIA ROCIO |
Apoderado |
Cese: 27/02/2023 | DIAZ LOPEZ MARIA REYES |
Apoderado |
Nombramiento: 27/02/2023 | DIAZ LOPEZ IÑIGO |
Apoderado |
Nombramiento: 01/02/2023 | ASEGURADO Y JIMENEZ AUDITORES SL |
Auditor |
Nombramiento: 01/02/2023 | ASEGURADO Y JIMENEZ AUDITORES SL |
Auditor de cuentas consolidadas |
Nombramiento: 18/01/2023 | QIANLONG SL |
Consejero |
Nombramiento: 18/01/2023 | DIAZ LOPEZ JOSE LUIS |
Representante |
Nombramiento: 17/01/2023 | ASEGURADO Y JIMENEZ AUDITORES SL |
Auditor de cuentas consolidadas |
Nombramiento: 28/01/2020 | ASEGURADO Y JIMENEZ AUDITORES SL |
Auditor |
Nombramiento: 25/05/2017 | DE MARCOS JIMENEZ ANTONIO |
Apoderado solidario |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por DEHESA DE LAS CABRERIZAS SL
25/02/2025 Detalles del anuncio (92756) Datos registrales: S 8 , H M 47090, I/A 57 (18.02.25).
- Revocaciones
Apoderado: DIAZ LOPEZ IÑIGO.
- Nombramientos
Apoderado: DIAZ LOPEZ IÑIGO.
16/02/2024 Detalles del anuncio (83744) Datos registrales: T 43980 , F 187, S 8, H M 47090, I/A 56 ( 9.02.24).
- Nombramientos
Auditor: AUDITORES Y CENSORES ASOCIADOS SL.
30/11/2023 Detalles del anuncio (511190) Datos registrales: T 43980 , F 183, S 8, H M 47090, I/A 55 (23.11.23).
- Fusión por Absorción
Sociedades absorbidas: GI 3 SL.
03/08/2023 Detalles del anuncio (349230) Datos registrales: T 43980 , F 181, S 8, H M 47090, I/A 53 (27.07.23).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: DIAZ LOPEZ MARIA REYES;DIAZ LOPEZ CARLOS. Presidente: DIAZ LOPEZ MARIA REYES.
- Nombramientos
Representan: DIAZ LOPEZ CARLOS LUIS;DIAZ LOPEZ MARIA REYES. Consejero: ALDEBARAN CHARTERS SL;SAESDI CONSULTING SL. Presidente: DIAZ LOPEZ IÑIGO.
03/08/2023 Detalles del anuncio (349231) Datos registrales: T 43980 , F 182, S 8, H M 47090, I/A 54 (27.07.23).
- Nombramientos
Apoderado: DIAZ LOPEZ MARIA ROCIO.
27/02/2023 Detalles del anuncio (101344) Datos registrales: T 43980 , F 180, S 8, H M 47090, I/A 52 (20.02.23).
- Revocaciones
Apoderado: DIAZ LOPEZ MARIA REYES.
- Nombramientos
Apoderado: DIAZ LOPEZ IÑIGO.
01/02/2023 Detalles del anuncio (54375) Datos registrales: T 43980 , F 180, S 8, H M 47090, I/A 51 (25.01.23).
- Nombramientos
Auditor: ASEGURADO Y JIMENEZ AUDITORES SL.
- Reelecciones
Aud.C.Con.: ASEGURADO Y JIMENEZ AUDITORES SL.
18/01/2023 Detalles del anuncio (27358) Datos registrales: T 16844 , F 61, S 8, H M 47090, I/A 50 (11.01.23).
- Nombramientos
Consejero: QIANLONG SL. Representan: DIAZ LOPEZ JOSE LUIS.
- Ampliación del Objeto Social
LA INVERSION DE CAPITAL EN ACTIVOS FINANCIEROS O INMOBILIARIOS Y LA ADQUISICION, GESTION, ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE VALORES REEPRESENTATIVOS DE LOS FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES RESIDENTES O NO RESIDENTES EN TERRITORIO ESPAÑOL...
17/01/2023 Detalles del anuncio (24677) Datos registrales: T 16844 , F 55, S 8, H M 47090, I/A 48 (21.01.20).
- Nombramientos
Aud.C.Con.: ASEGURADO Y JIMENEZ AUDITORES SL.
- Fe de erratas
Se omitió por error en la inscripción 48ª la publicación del nombramiento de ASEGURADO Y JIMENEZ AUDITORES SL como auditor de cuentas consolidadas para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
21/01/2022 Detalles del anuncio (28560) Datos registrales: T 16844 , F 55, S 8, H M 47090, I/A 49 (14.01.22).
- Reducción de Capital
Importe reducción: 38.106,32 Euros. Resultante Suscrito: 3.233.593,44 Euros.
- Escisión Parcial
Sociedades beneficiarias de la escisión: FINCA LA TOLEDANA SL.
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 26
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
---|---|---|---|
BORME-A-2025-38-28 | 25/02/2025 | Madrid | Descargar |
BORME-A-2024-34-28 | 16/02/2024 | Madrid | Descargar |
BORME-A-2023-228-28 | 30/11/2023 | Madrid | Descargar |
BORME-A-2023-147-28 | 03/08/2023 | Madrid | Descargar |
BORME-A-2023-147-28 | 03/08/2023 | Madrid | Descargar |
BORME-A-2023-40-28 | 27/02/2023 | Madrid | Descargar |
BORME-A-2023-22-28 | 01/02/2023 | Madrid | Descargar |
BORME-A-2023-12-28 | 18/01/2023 | Madrid | Descargar |
BORME-A-2023-11-28 | 17/01/2023 | Madrid | Descargar |
BORME-A-2022-14-28 | 21/01/2022 | Madrid | Descargar |