CXG AVIVA CORPORACION CAIXAGALICIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA

Cambio de denominación social

Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 29/01/2015

IZQUIERDO SAUGAR IGNACIO

Consejero
Cese: 29/01/2015

BUJANDA CASTILLO ALFONSO

Secretario
Cese: 29/01/2015

FC 40 SPV INTERNATIONAL SL

Consejero
Cese: 29/01/2015

PICAZO ABAD CONSTANCIO

Consejero
Cese: 29/01/2015

IZQUIERDO SAUGAR IGNACIO

Presidente
Cese: 29/01/2015

MATHEW STEWART NEIL

Consejero
Cese: 29/01/2015

RODRIGUEZ CALLE SAMUEL

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 29/01/2015

ROA SOTILLOS IVANA

Apoderado solidario
Cese: 29/01/2015

IZQUIERDO SAUGAR IGNACIO

Apoderado
Nombramiento: 29/01/2015

CORPORACION EMPRESARIAL DE TENENCIA DE ACTIVOS DE

Consejero
Nombramiento: 29/01/2015

CXG GESTION INMOBILIARIA CORPORACION CAIXAGALICIA

Presidente
Nombramiento: 29/01/2015

BESCANSA ALONSO JUAN PEDRO

Secretario
Cese: 07/01/2015

ARRECHEA DE MIGUEL LUIS IGNACIO

Vicesecretario
Nombramiento: 07/01/2015

PAZ BIBEL ANDRES- OSCAR

Vicesecretario
Cese: 05/12/2014

SANTAOLALLA DEL OJO LETICIA

Apoderado
Cese: 05/12/2014

PARIS SALCEDO CARLOS

Apoderado solidario
Nombramiento: 30/10/2014

GUTIERREZ MERINO CARLOS

Apoderado solidario
Nombramiento: 30/10/2014

LORENZO ROBLA PALOMA

Apoderado solidario
Cese: 30/04/2014

ANGULO RUBIO DAVID

Consejero
Nombramiento: 30/04/2014

MATHEW STEWART NEIL

Consejero
Nombramiento: 11/04/2014

BENITO DOMINGO ALFONSO

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 11/04/2014

FERNANDEZ FERNANDEZ ALBERTO

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 11/04/2014

VENTURA TREDECI CHRISTIAN

Apoderado mancomunado solidario

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por CXG AVIVA CORPORACION CAIXAGALICIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA

29/01/2015 Detalles del anuncio (39264) Datos registrales: T 3403 , F 27, S 8, H C 6245, I/A 160 (22.01.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: IZQUIERDO SAUGAR IGNACIO. Secretario: BUJANDA CASTILLO ALFONSO. Consejero: FC 40 SPV INTERNATIONAL SL;PICAZO ABAD CONSTANCIO. Presidente: IZQUIERDO SAUGAR IGNACIO. Consejero: MATHEW STEWART NEIL.

  • Revocaciones

    Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ CALLE SAMUEL. Apo.Sol.: ROA SOTILLOS IVANA. Apoderado: IZQUIERDO SAUGAR IGNACIO.

  • Nombramientos

    Consejero: CORPORACION EMPRESARIAL DE TENENCIA DE ACTIVOS DE. Presidente: CXG GESTION INMOBILIARIA CORPORACION CAIXAGALICIA. Secretario: BESCANSA ALONSO JUAN PEDRO.

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: RELATIVO A LA DENOMINACION SOCIAL.-.

  • Cambio de denominación social

    ABANCA VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS SA.

07/01/2015 Detalles del anuncio (2281) Datos registrales: T 3282 , F 25, S 8, H C 6245, I/A 159 (29.12.14).

  • Otros Conceptos

    Se sustituye a Don Juan Francisco Díaz Arnau por DON GABRIEL GONZALEZ EIROA como representante persona física del Consejero VIBARCO, S.L..

07/01/2015 Detalles del anuncio (2280) Datos registrales: T 3282 , F 25, S 8, H C 6245, I/A 158 (29.12.14).

  • Ceses/Dimisiones

    Vicesecret.: ARRECHEA DE MIGUEL LUIS IGNACIO.

  • Nombramientos

    Vicesecret.: PAZ BIBEL ANDRES- OSCAR.

05/12/2014 Detalles del anuncio (497872) Datos registrales: T 3282 , F 25, S 8, H C 6245, I/A 157 (28.11.14).

  • Revocaciones

    Apoderado: SANTAOLALLA DEL OJO LETICIA.

05/12/2014 Detalles del anuncio (497871) Datos registrales: T 3282 , F 25, S 8, H C 6245, I/A 156 (28.11.14).

  • Revocaciones

    Apo.Sol.: PARIS SALCEDO CARLOS.

06/11/2014 Detalles del anuncio (447892) Datos registrales: T 3282 , F 25, S 8, H C 6245, I/A 155 (27.10.14).

  • Desembolso de divindendos pasivos

    Desembolsado: 10.500.011,76 Euros.

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: 5º. Capital.-.

30/10/2014 Detalles del anuncio (437207) Datos registrales: T 3282 , F 24, S 8, H C 6245, I/A 153 (23.10.14).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: GUTIERREZ MERINO CARLOS.

30/10/2014 Detalles del anuncio (437208) Datos registrales: T 3282 , F 24, S 8, H C 6245, I/A 154 (23.10.14).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: LORENZO ROBLA PALOMA.

08/08/2014 Detalles del anuncio (327078) Datos registrales: T 3282 , F 24, S 8, H C 6245, I/A 152 ( 1.08.14).

  • Otros Conceptos

    Subsanado el primer apellido del apoderado, cuyo poder motivó la inscripción 144&, inscrito como Don José María Diez Vallejo, cuando es Don José María DIAZ Vallejo.-

  • Fe de erratas

    En el BORME nº 71, de fecha 11-4-2014, bajo el nº 01626802014, se publicó laq concesión de poder a favor de Don José Maria Diez Vallejo, cuando dicho apoderado es Don José María DIAZ Vallejo.-

11/06/2014 Detalles del anuncio (244779) Datos registrales: T 3282 , F 24, S 8, H C 6245, I/A 151 ( 4.06.14).

  • Otros Conceptos

    SE SUTITUYE A DON RUBEN MARTINEZ NIETO POR DON ALVARO VALENTIN GARCIA DIEGUEZ COMO REPRESENTANTE PERSONA FISICA DEL CONSEJERO CXG AVIVA CORPORACION CAIXAGALICIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 74

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2015-19-15 29/01/2015 Coruña, A Descargar
BORME-A-2015-3-15 07/01/2015 Coruña, A Descargar
BORME-A-2015-3-15 07/01/2015 Coruña, A Descargar
BORME-A-2014-233-15 05/12/2014 Coruña, A Descargar
BORME-A-2014-233-15 05/12/2014 Coruña, A Descargar
BORME-A-2014-213-15 06/11/2014 Coruña, A Descargar
BORME-A-2014-208-15 30/10/2014 Coruña, A Descargar
BORME-A-2014-208-15 30/10/2014 Coruña, A Descargar
BORME-A-2014-150-15 08/08/2014 Coruña, A Descargar
BORME-A-2014-109-15 11/06/2014 Coruña, A Descargar