CP PROXIMITY MADRID SA

Extinta

Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 07/12/2011

FERRER LORENZO JOSE IGNACIO

Apoderado
Cese: 07/12/2011

MARTINEZ PEREZ CONCHA

Apoderado
Cese: 07/12/2011

RAMIS PLA JOAQUIM

Apoderado
Cese: 07/12/2011

GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN

Apoderado
Cese: 07/12/2011

BARRAGAN FERNANDEZ LUIS JAVIER

Apoderado
Cese: 07/12/2011

BALSERA GARCIA MANUEL

Apoderado
Nombramiento: 07/12/2011

FERRER LORENZO JOSE IGNACIO

Apoderado
Nombramiento: 07/12/2011

MARTINEZ PEREZ CONCHA

Apoderado
Nombramiento: 07/12/2011

RAMIS PLA JOAQUIM

Apoderado
Nombramiento: 07/12/2011

GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN

Apoderado
Nombramiento: 07/12/2011

BARRAGAN FERNANDEZ LUIS JAVIER

Apoderado
Nombramiento: 17/10/2011

KPMG AUDITORES SL

Auditor
Cese: 22/06/2011

FERRER LORENZO JOSE IGNACIO

Apoderado
Cese: 22/06/2011

MARTINEZ PEREZ CONCHA

Apoderado
Cese: 22/06/2011

RAMIS PLA JOAQUIM

Apoderado
Cese: 22/06/2011

BAÑUELOS DE LUCAS MIGUEL ANGEL

Apoderado
Cese: 22/06/2011

BARRAGAN FERNANDEZ LUIS

Apoderado
Nombramiento: 22/06/2011

FERRER LORENZO JOSE IGNACIO

Apoderado
Nombramiento: 22/06/2011

MARTINEZ PEREZ CONCHA

Apoderado
Nombramiento: 22/06/2011

RAMIS PLA JOAQUIM

Apoderado
Nombramiento: 22/06/2011

GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN

Apoderado
Nombramiento: 22/06/2011

BARRAGAN FERNANDEZ LUIS JAVIER

Apoderado
Nombramiento: 22/06/2011

BALSERA GARCIA MANUEL

Apoderado
Cese: 22/09/2010

PASTOR ESTEBAN ALBERTO

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 22/09/2010

MEDINA EXPOSITO PABLO JESUS

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 22/09/2010

FERRER LORENZO JOSE IGNACIO

Apoderado mancomunado
Cese: 22/09/2010

MARTINEZ PEREZ CONCHA

Apoderado mancomunado
Cese: 22/09/2010

RAMIS PLA JOAQUIM

Apoderado mancomunado
Cese: 22/09/2010

BAÑUELOS DE LUCAS MIGUEL ANGEL

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 22/09/2010

FERRER LORENZO JOSE IGNACIO

Apoderado
Nombramiento: 22/09/2010

MARTINEZ PEREZ CONCHA

Apoderado
Nombramiento: 22/09/2010

RAMIS PLA JOAQUIM

Apoderado
Nombramiento: 22/09/2010

BAÑUELOS DE LUCAS MIGUEL ANGEL

Apoderado
Nombramiento: 22/09/2010

BARRAGAN FERNANDEZ LUIS

Apoderado

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por CP PROXIMITY MADRID SA

17/07/2012 Detalles del anuncio (300636) Datos registrales: T 23370 , F 225, S 8, H M 100941, I/A 48 (25.06.12).

  • Otros Conceptos

    ABSORBIDA POR LA DOMICILIADA EN BARCELONA ORBITAL PROXIMITYSL.

  • Extinción

12/04/2012 Detalles del anuncio (164187) Datos registrales: T 23370 , F 225, S 8, H M 100941, I/A 47/M (28.03.12).

  • Otros Conceptos

    Cierre provisional de la hoja social por plazo de SEIS MESES de conformidad con lo preceptuado en el artículo 231 R.R.M.

07/12/2011 Detalles del anuncio (487782) Datos registrales: T 23370 , F 224, S 8, H M 100941, I/A 47 (24.11.11).

  • Revocaciones

    Apoderado: FERRER LORENZO JOSE IGNACIO;MARTINEZ PEREZ CONCHA;RAMIS PLA JOAQUIM;GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN;BARRAGAN FERNANDEZ LUIS JAVIER;BALSERA GARCIA MANUEL.

  • Nombramientos

    Apoderado: FERRER LORENZO JOSE IGNACIO;MARTINEZ PEREZ CONCHA;RAMIS PLA JOAQUIM;GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN;BARRAGAN FERNANDEZ LUIS JAVIER.

17/10/2011 Detalles del anuncio (410399) Datos registrales: T 23370 , F 224, S 8, H M 100941, I/A 46 ( 5.10.11).

  • Reelecciones

    Auditor: KPMG AUDITORES SL.

22/06/2011 Detalles del anuncio (266862) Datos registrales: T 23370 , F 223, S 8, H M 100941, I/A 45 (10.06.11).

  • Revocaciones

    Apoderado: FERRER LORENZO JOSE IGNACIO;MARTINEZ PEREZ CONCHA;RAMIS PLA JOAQUIM;BAÑUELOS DE LUCAS MIGUEL ANGEL;BARRAGAN FERNANDEZ LUIS.

  • Nombramientos

    Apoderado: FERRER LORENZO JOSE IGNACIO;MARTINEZ PEREZ CONCHA;RAMIS PLA JOAQUIM;GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN;BARRAGAN FERNANDEZ LUIS JAVIER;BALSERA GARCIA MANUEL.

12/11/2010 Detalles del anuncio (1037335)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Octubre de 2010) Año: 2009

22/09/2010 Detalles del anuncio (359011) Datos registrales: T 23370 , F 222, S 8, H M 100941, I/A 44 (13.09.10).

  • Revocaciones

    Apo.Man.Soli: PASTOR ESTEBAN ALBERTO;MEDINA EXPOSITO PABLO JESUS. Apo.Manc.: FERRER LORENZO JOSE IGNACIO;MARTINEZ PEREZ CONCHA;RAMIS PLA JOAQUIM;BAÑUELOS DE LUCAS MIGUEL ANGEL.

  • Nombramientos

    Apoderado: FERRER LORENZO JOSE IGNACIO;MARTINEZ PEREZ CONCHA;RAMIS PLA JOAQUIM;BAÑUELOS DE LUCAS MIGUEL ANGEL;BARRAGAN FERNANDEZ LUIS.

11/03/2010 Detalles del anuncio (126472)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Febrero de 2010) Año: 2008

29/07/2009 Detalles del anuncio (335270) Datos registrales: T 23370 , F 218, S 8, H M 100941, I/A 43 (17.07.09).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 59.883,64 Euros. Resultante Suscrito: 240.183,64 Euros.

04/06/2009 Detalles del anuncio (138299)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Mayo de 2009) Año: 2007

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 12

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2012-135-28 17/07/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-70-28 12/04/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2011-231-28 07/12/2011 Madrid Descargar
BORME-A-2011-197-28 17/10/2011 Madrid Descargar
BORME-A-2011-119-28 22/06/2011 Madrid Descargar
BORME-B-2010-217-28 12/11/2010 Madrid Descargar
BORME-A-2010-183-28 22/09/2010 Madrid Descargar
BORME-B-2010-48-28 11/03/2010 Madrid Descargar
BORME-A-2009-142-28 29/07/2009 Madrid Descargar
BORME-B-2009-104-28 04/06/2009 Madrid Descargar