COVALBLOCK SL
Extinta
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Cese: 12/06/2012 | PURON FERNANDEZ ANGEL MANUEL GERARDO |
Administrador único |
| Cese: 02/03/2012 | PURON FERNANDEZ ANGEL |
Consejero |
| Cese: 02/03/2012 | FERRANDO DE LA CUADRA ANTONIO MARIA |
Consejero |
| Cese: 02/03/2012 | PURON FERNANDEZ ANGEL |
Consejero delegado |
| Cese: 02/03/2012 | FERRANDO CUADRA IGNACIO |
Consejero |
| Cese: 02/03/2012 | GOMEZ ORTIZ JULIO |
Consejero |
| Cese: 02/03/2012 | FERRANDO DE LA CUADRA ANTONIO MARIA |
Presidente |
| Cese: 02/03/2012 | FONT DE LA CUADRA BEATRIZ |
Consejero |
| Cese: 02/03/2012 | DE LA PAZ MARTINEZ MANUEL TORIBIO |
Consejero |
| Cese: 02/03/2012 | FERRANDO CUADRA IGNACIO |
Secretario |
| Nombramiento: 02/03/2012 | PURON FERNANDEZ ANGEL MANUEL GERARDO |
Administrador único |
| Cese: 21/06/2010 | RAMOS ARRIERO ANTONIO |
Consejero |
| Cese: 21/06/2010 | ARGENTE PEREZ ESTEBAN |
Consejero |
| Cese: 21/06/2010 | RAMOS ARRIERO ANTONIO |
Secretario |
| Cese: 21/06/2010 | FERRANDO DE LA CUADRA FRANCISCO JAVIER |
Consejero |
| Nombramiento: 21/06/2010 | FONT DE LA CUADRA BEATRIZ |
Consejero |
| Nombramiento: 21/06/2010 | DE LA PAZ MARTINEZ MANUEL TORIBIO |
Consejero |
| Nombramiento: 21/06/2010 | FERRANDO CUADRA IGNACIO |
Secretario |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por COVALBLOCK SL
17/11/2016 Detalles del anuncio (465997) Datos registrales: T 6930, L 4233, F 210, S 8, H V 78221, I/A (10.11.16).
- Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas
19/08/2015 Detalles del anuncio (345180) Datos registrales: T 6930, L 4233, F 210, S 8, H V 78221, I/A 9 (12.08.15).
- Situación Concursal
Procedimiento concursal 352/2012. FIRME: Si, Fecha de resolución 17/07/2015. Auto de conclusión del concurso. Insuficiencia de la masa activa. Juzgado: num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA. Juez: JOSE MARIA CUTILLAS TORNS.
- Situación Concursal
Procedimiento concursal 352/2012. Fecha de resolución 15/05/2012. Revocación de administradores concursales. Juzgado: num. 3 DE LO MERCANTIL. Juez: JOSE MARIA CUTILLAS TORNS. Administrador Concursal. Fecha 17/07/2015, NIF/CIF 29021399E. GINER GOMEZ JULIO CESAR.
- Situación Concursal
Procedimiento concursal 352/2012. FIRME: Si, Fecha de resolución 17/07/2015. Cese de las limitaciones de las facultades de administración. Juzgado: num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA. Juez: JOSE MARIA CUTILLAS TORNS.
- Extinción
12/06/2012 Detalles del anuncio (248276) Datos registrales: T 6930, L 4233, F 209, S 8, H V 78221, I/A 8 ( 1.06.12).
- Ceses/Dimisiones
Adm. Unico: PURON FERNANDEZ ANGEL MANUEL GERARDO.
- Situación Concursal
Procedimiento concursal 352/2012. FIRME: Si, Fecha de resolución 15/05/2012. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 3 DE LO MERCANTIL. Juez: JOSE MARIA CUTILLAS TORNS.
- Situación Concursal
Procedimiento concursal 352/2012. Fecha de resolución 15/05/2012. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 3 DE LO MERCANTIL. Juez: JOSE MARIA CUTILLAS TORNS. Administrador Concursal. Fecha 15/05/2012, NIF/CIF 29021399E. GINER GOMEZ JULIO CESAR.
- Situación Concursal
Procedimiento concursal 352/2012. FIRME: Si, Fecha de resolución 15/05/2012. Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado. Juzgado: num. 3 DE LO MERCANTIL. Juez: JOSE MARIA CUTILLAS TORNS.
- Disolución
Otras Causas.
02/03/2012 Detalles del anuncio (104616) Datos registrales: T 6930, L 4233, F 209, S 8, H V 78221, I/A 7 (22.02.12).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: PURON FERNANDEZ ANGEL;FERRANDO DE LA CUADRA ANTONIO MARIA. Con.Delegado: PURON FERNANDEZ ANGEL. Consejero: FERRANDO CUADRA IGNACIO;GOMEZ ORTIZ JULIO. Presidente: FERRANDO DE LA CUADRA ANTONIO MARIA. Consejero: FONT DE LA CUADRA BEATRIZ;DE LA PAZ MARTINEZ MANUEL TORIBIO. Secretario: FERRANDO CUADRA IGNACIO.
- Nombramientos
Adm. Unico: PURON FERNANDEZ ANGEL MANUEL GERARDO.
- Modificaciones Estatutarias
Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.
26/09/2011 Detalles del anuncio (623659)
- Depósitos de cuentas anuales
(Septiembre de 2011) Año: 2010
20/10/2010 Detalles del anuncio (389444) Datos registrales: T 6930, L 4233, F 209, S 8, H V 78221, I/A 6 ( 8.10.10).
- Ampliación de Capital
Capital: 100.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 483.138,00 Euros.
23/09/2010 Detalles del anuncio (662970)
- Depósitos de cuentas anuales
(Septiembre de 2010) Año: 2009
21/06/2010 Detalles del anuncio (246810) Datos registrales: T 6930, L 4233, F 209, S 8, H V 78221, I/A 5 (10.06.10).
- Ceses/Dimisiones
Consejero: RAMOS ARRIERO ANTONIO;ARGENTE PEREZ ESTEBAN. Secretario: RAMOS ARRIERO ANTONIO. Consejero: FERRANDO DE LA CUADRA FRANCISCO JAVIER.
- Nombramientos
Consejero: FONT DE LA CUADRA BEATRIZ;DE LA PAZ MARTINEZ MANUEL TORIBIO. Secretario: FERRANDO CUADRA IGNACIO.
11/09/2009 Detalles del anuncio (403506)
- Depósitos de cuentas anuales
(Septiembre de 2009) Año: 2008
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 9
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2016-219-46 | 17/11/2016 | Valencia/València | Descargar |
| BORME-A-2015-157-46 | 19/08/2015 | Valencia/València | Descargar |
| BORME-A-2012-110-46 | 12/06/2012 | Valencia/València | Descargar |
| BORME-A-2012-44-46 | 02/03/2012 | Valencia/València | Descargar |
| BORME-B-2011-183-46 | 26/09/2011 | Valencia/València | Descargar |
| BORME-A-2010-202-46 | 20/10/2010 | Valencia/València | Descargar |
| BORME-B-2010-184-46 | 23/09/2010 | Valencia/València | Descargar |
| BORME-A-2010-116-46 | 21/06/2010 | Valencia/València | Descargar |
| BORME-B-2009-174-46 | 11/09/2009 | Valencia/València | Descargar |