COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING SL

Cambio de denominación social

AVDA CASTILLA 2 1º - EDIFICION DUBLIN (SAN FERNANDO DE HENARES).
Madrid
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 14/06/2024

PKF AUDIEC SA

Auditor
Nombramiento: 18/10/2021

JIMENEZ BORRAS CARLOS

Apoderado solidario
Nombramiento: 18/10/2021

MANERO MORENO CARLOS

Apoderado solidario
Cese: 11/12/2015

CORTADA CAMPOS FRANCISCO JAVIER

Administrador único
Nombramiento: 11/12/2015

CARLES PLA JOSE LUIS

Administrador único
Nombramiento: 11/12/2015

CORTADA CAMPOS FRANCISCO JAVIER

Administrador único
Cese: 01/08/2013

CARLES PLA JOSE LUIS

Administrador único
Cese: 07/08/2012

CORTADA CAMPOS FRANCISCO JAVIER

Administrador
Nombramiento: 07/08/2012

CARLES PLA JOSE LUIS

Administrador único
Cese: 11/02/2010

ALIAS PEREZ DORINDA

Apoderado

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING SL

17/06/2024 Detalles del anuncio (272056) Datos registrales: S 8 , H M 663032, I/A 9 (10.06.24).

  • Cambio de denominación social

    ADASOFT EMPOWERING FACTORIES SL.

14/06/2024 Detalles del anuncio (270593) Datos registrales: S 8 , H M 663032, I/A 8 ( 7.06.24).

  • Nombramientos

    Auditor: PKF AUDIEC SA.

09/01/2024 Detalles del anuncio (11170) Datos registrales: T 43062 , F 173, S 8, H M 663032, I/A 7 (29.12.23).

  • Cambio de domicilio social

    AVDA CASTILLA 2 1º - EDIFICION DUBLIN (SAN FERNANDO DE HENARES).

26/04/2022 Detalles del anuncio (185462) Datos registrales: T 37147 , F 35, S 8, H M 663032, I/A 6 (19.04.22).

  • Pérdida del carácter de unipersonalidad

18/10/2021 Detalles del anuncio (457215) Datos registrales: T 37147 , F 35, S 8, H M 663032, I/A 5 ( 8.10.21).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: JIMENEZ BORRAS CARLOS.

18/10/2021 Detalles del anuncio (457214) Datos registrales: T 37147 , F 33, S 8, H M 663032, I/A 4 ( 8.10.21).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: MANERO MORENO CARLOS.

24/01/2020 Detalles del anuncio (32290) Datos registrales: T 37147 , F 33, S 8, H M 663032, I/A 3 (17.01.20).

    09/02/2018 Detalles del anuncio (66183) Datos registrales: T 37147 , F 33, S 8, H M 663032, I/A 2 ( 1.02.18).

    • Cambio de domicilio social

      CRA DE SAN JERONIMO 15 - PALACIO DE MIRAFLORES (MADRID).

    05/01/2018 Detalles del anuncio (6976) Datos registrales: T 40832 , F 181, S 8, H B 256662, I/A 17 (12.12.17).

    • Modificaciones Estatutarias

      ART.22.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL.

    14/12/2015 Detalles del anuncio (504652) Datos registrales: T 40832 , F 181, S 8, H B 256662, I/A 16 ( 4.12.15).

    • Cambio de domicilio social

      AV BARCELONA Num.115 P.1 PTA.3 (SANT JOAN DESPI).

    Documentos del Registro Mercantil relacionados: 20

    #CVE
    Fecha
    Provincia
    BORME-A-2024-115-28 17/06/2024 Madrid Descargar
    BORME-A-2024-114-28 14/06/2024 Madrid Descargar
    BORME-A-2024-6-28 09/01/2024 Madrid Descargar
    BORME-A-2022-79-28 26/04/2022 Madrid Descargar
    BORME-A-2021-200-28 18/10/2021 Madrid Descargar
    BORME-A-2021-200-28 18/10/2021 Madrid Descargar
    BORME-A-2020-16-28 24/01/2020 Madrid Descargar
    BORME-A-2018-29-28 09/02/2018 Madrid Descargar
    BORME-A-2018-4-08 05/01/2018 Barcelona Descargar
    BORME-A-2015-237-08 14/12/2015 Barcelona Descargar