COMANSI SL
Extinta
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Cese: 27/07/2022 | RODRIGUEZ & SAPENA CONCURSALISTAS SLP |
Administrador concurs. |
| Cese: 27/07/2022 | RODRIGUEZ CONDE CARLOS |
Representante administrador concurs. |
| Cese: 30/03/2021 | FALGAS MARIN FERNANDO |
Administrador único |
| Nombramiento: 23/10/2019 | RODRIGUEZ & SAPENA CONCURSALISTAS SLP |
Administrador concurs. |
| Nombramiento: 23/10/2019 | RODRIGUEZ CONDE CARLOS |
Representante administrador concurs. |
| Cese: 31/01/2019 | FALGAS MARIN FERNANDO |
Consejero |
| Cese: 31/01/2019 | FALGAS MARIN FERNANDO |
Presidente |
| Cese: 31/01/2019 | ROSSINES DE TEMPLE DANIEL |
Consejero |
| Cese: 31/01/2019 | ROSSINES DE TEMPLE DANIEL |
Consejero delegado |
| Cese: 31/01/2019 | VELASCO BENITEZ JOSE |
Consejero |
| Cese: 31/01/2019 | VELASCO BENITEZ JOSE |
Secretario |
| Cese: 31/01/2019 | FALGAS MARIN FERNANDO |
Consejero delegado |
| Nombramiento: 31/01/2019 | FALGAS MARIN FERNANDO |
Administrador único |
| Cese: 20/06/2018 | BAKER TILLY FMAC SLP |
Auditor de cuentas |
| Nombramiento: 20/06/2018 | BOVE MONTERO Y ASOCIADOS SL |
Auditor de cuentas |
| Nombramiento: 25/04/2017 | BAKER TILLY FMAC SLP |
Auditor de cuentas |
| Cese: 18/02/2015 | FALGAS MARIN FERNANDO |
Consejero delegado mancomunado |
| Cese: 18/02/2015 | VELASCO BENITEZ JOSE |
Consejero delegado mancomunado |
| Nombramiento: 18/02/2015 | FALGAS MARIN FERNANDO |
Consejero delegado |
| Cese: 26/01/2015 | B B AVENTURERO SL |
Administrador conjunto |
| Cese: 26/01/2015 | FALGAS MARIN FERNANDO |
Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil |
| Cese: 26/01/2015 | ROSSINES DE TEMPLE DANIEL |
Administrador conjunto |
| Nombramiento: 26/01/2015 | FALGAS MARIN FERNANDO |
Consejero |
| Nombramiento: 26/01/2015 | FALGAS MARIN FERNANDO |
Presidente |
| Nombramiento: 26/01/2015 | FALGAS MARIN FERNANDO |
Consejero delegado mancomunado |
| Nombramiento: 26/01/2015 | ROSSINES DE TEMPLE DANIEL |
Consejero |
| Nombramiento: 26/01/2015 | ROSSINES DE TEMPLE DANIEL |
Consejero delegado |
| Nombramiento: 26/01/2015 | VELASCO BENITEZ JOSE |
Consejero |
| Nombramiento: 26/01/2015 | VELASCO BENITEZ JOSE |
Secretario |
| Nombramiento: 26/01/2015 | VELASCO BENITEZ JOSE |
Consejero delegado mancomunado |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por COMANSI SL
27/07/2022 Detalles del anuncio (345630) Datos registrales: T 41882 , F 103, S 8, H B 263009, I/A 18 (19.07.22).
- Revocaciones
ADM.CONCURS.: RODRIGUEZ & SAPENA CONCURSALISTAS SLP. REP.ADM.CONC: RODRIGUEZ CONDE CARLOS.
- Otros Conceptos
JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 512/2019, AUTO FIRME DE FECHA 29/06/2022, POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD.
- Extinción
30/03/2021 Detalles del anuncio (147402) Datos registrales: T 41882 , F 102, S 8, H B 263009, I/A 17 (23.03.21).
- Revocaciones
ADM.UNICO: FALGAS MARIN FERNANDO.
- Otros Conceptos
JUZGADO MERCANTIL NUMERO 5 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 512/2019, AUTOS FIRMES DE FECHAS: 21/02/2020, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION; 27/10/2020, APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION Y 26/01/2021, ARCHIVO SECCION SEXTA.
- Disolución
Judicial.
25/05/2020 Detalles del anuncio (162510) Datos registrales: T 41882 , F 102, S 8, H B 263009, I/A 16 (15.05.20).
- Cambio de domicilio social
CL DEL MIG Num.157 (HOSPITALET DE LLOBREGAT (L).
23/10/2019 Detalles del anuncio (438901) Datos registrales: T 37171 , F 30, S 8, H B 263009, I/A 15 (16.10.19).
- Nombramientos
ADM.CONCURS.: RODRIGUEZ & SAPENA CONCURSALISTAS SLP. REP.ADM.CONC: RODRIGUEZ CONDE CARLOS.
- Otros Conceptos
JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 512/2019, AUTOS FIRMES, DE 12/03/2019: DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y DE 18/07/2019: FINALIZACION FASE COMUN Y APERTURA Y APERTURA FASE DE CONVENIO.
31/01/2019 Detalles del anuncio (43679) Datos registrales: T 37171 , F 30, S 8, H B 263009, I/A 14 (24.01.19).
- Revocaciones
CONSEJERO: FALGAS MARIN FERNANDO. PRESIDENTE: FALGAS MARIN FERNANDO. CONSEJERO: ROSSINES DE TEMPLE DANIEL. CONS. DELEG.: ROSSINES DE TEMPLE DANIEL. CONSEJERO: VELASCO BENITEZ JOSE. SECRETARIO: VELASCO BENITEZ JOSE. CONS. DELEG.: FALGAS MARIN FERNANDO.
- Nombramientos
ADM.UNICO: FALGAS MARIN FERNANDO.
20/06/2018 Detalles del anuncio (258706) Datos registrales: T 37171 , F 30, S 8, H B 263009, I/A 13 (12.06.18).
- Revocaciones
AUDIT.CUENT.: BAKER TILLY FMAC SLP.
- Nombramientos
AUDIT.CUENT.: BOVE MONTERO Y ASOCIADOS SL.
25/04/2017 Detalles del anuncio (176176) Datos registrales: T 37171 , F 29, S 8, H B 263009, I/A 12 (13.04.17).
- Nombramientos
AUDIT.CUENT.: BAKER TILLY FMAC SLP.
18/02/2015 Detalles del anuncio (71669) Datos registrales: T 37171 , F 29, S 8, H B 263009, I/A 11 (10.02.15).
- Revocaciones
CONS.DEL.MAN: FALGAS MARIN FERNANDO;VELASCO BENITEZ JOSE.
- Nombramientos
CONS. DELEG.: FALGAS MARIN FERNANDO.
26/01/2015 Detalles del anuncio (31208) Datos registrales: T 37171 , F 28, S 8, H B 263009, I/A 10 (16.01.15).
- Revocaciones
ADM.CONJUNTO: B B AVENTURERO SL. REPR.143 RRM: FALGAS MARIN FERNANDO. ADM.CONJUNTO: ROSSINES DE TEMPLE DANIEL.
- Nombramientos
CONSEJERO: FALGAS MARIN FERNANDO. PRESIDENTE: FALGAS MARIN FERNANDO. CONS.DEL.MAN: FALGAS MARIN FERNANDO. CONSEJERO: ROSSINES DE TEMPLE DANIEL. CONS. DELEG.: ROSSINES DE TEMPLE DANIEL. CONSEJERO: VELASCO BENITEZ JOSE. SECRETARIO: VELASCO BENITEZ JOSE. CONS.DEL.MAN: VELASCO BENITEZ JOSE.
- Modificaciones Estatutarias
ART.13.- JUNTAS GENERALES. ART.18.- ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL.
26/10/2011 Detalles del anuncio (851945)
- Depósitos de cuentas anuales
(Septiembre de 2011) Año: 2010
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 10
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2022-142-08 | 27/07/2022 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2021-60-08 | 30/03/2021 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2020-98-08 | 25/05/2020 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2019-204-08 | 23/10/2019 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2019-21-08 | 31/01/2019 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2018-117-08 | 20/06/2018 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2017-78-08 | 25/04/2017 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2015-33-08 | 18/02/2015 | Barcelona | Descargar |
| BORME-A-2015-16-08 | 26/01/2015 | Barcelona | Descargar |
| BORME-B-2011-204-08 | 26/10/2011 | Barcelona | Descargar |