CLICKSEGUROS SEGUROS Y REASEGUROS SA

Extinta

PLAZA DE LAS CORTES 8 (MADRID).
Madrid
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 02/07/2013

LUCENA LUCENA MARIA JOSE

Apoderado
Cese: 02/07/2013

ESCUDERO SANZ JOSE LUIS

Apoderado
Nombramiento: 22/05/2013

ESCRIBANO RUBIO JOSE MARIA

Apoderado
Cese: 21/02/2013

SERRAT MESEGAR FRANCISCO ANTONIO

Consejero
Cese: 21/02/2013

SERRAT MESEGAR FRANCISCO ANTONIO

Vicepresidente
Cese: 21/02/2013

SERRAT MESEGAR FRANCISCO ANTONIO

Consejero delegado
Cese: 04/02/2013

UZEL DOMINIQUE JEAN MARIE

Consejero
Cese: 04/02/2013

UZEL DOMINIQUE JEAN MARIE

Vicepresidente
Cese: 04/02/2013

UZEL DOMINIQUE JEAN MARIE

Consejero delegado
Nombramiento: 04/02/2013

SERRAT MESEGAR FRANCISCO ANTONIO

Consejero
Nombramiento: 04/02/2013

SERRAT MESEGAR FRANCISCO ANTONIO

Vicepresidente
Nombramiento: 04/02/2013

SERRAT MESEGAR FRANCISCO ANTONIO

Consejero delegado
Cese: 08/11/2012

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Nombramiento: 08/11/2012

DELOITTE SL

Auditor
Cese: 30/10/2012

LEON MARIE GHISLAIN LEFEVRE PIERRE PAUL JOSEPH

Consejero
Cese: 30/10/2012

LEON MARIE GHISLAIN LEFEVRE PIERRE PAUL JOSEPH

Presidente
Nombramiento: 30/10/2012

HILLAIRE FLORENT LOUIS JEAN

Presidente
Nombramiento: 01/06/2012

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Auditor
Cese: 01/03/2012

MADRID SANCHEZ CLEMENTE

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 01/03/2012

DE MARTIN SANCHEZ-PATON ENRIQUE

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 01/03/2012

SERRANO ORTIZ DE LUNA JAVIER

Apoderado
Nombramiento: 28/02/2012

HILLAIRE FLORENT LOUIS JEAN

Consejero

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por CLICKSEGUROS SEGUROS Y REASEGUROS SA

17/07/2014 Detalles del anuncio (296041) Datos registrales: T 23873 , F 59, S 8, H M 412233, I/A 71 ( 9.07.14).

  • Disolución

    Fusion.

  • Extinción

02/07/2013 Detalles del anuncio (300608) Datos registrales: T 23873 , F 58, S 8, H M 412233, I/A 70 (24.06.13).

  • Nombramientos

    Apoderado: LUCENA LUCENA MARIA JOSE.

02/07/2013 Detalles del anuncio (300607) Datos registrales: T 23873 , F 57, S 8, H M 412233, I/A 69 (24.06.13).

  • Revocaciones

    Apoderado: ESCUDERO SANZ JOSE LUIS.

22/05/2013 Detalles del anuncio (233645) Datos registrales: T 23873 , F 56, S 8, H M 412233, I/A 68 (13.05.13).

  • Nombramientos

    Apoderado: ESCRIBANO RUBIO JOSE MARIA.

01/04/2013 Detalles del anuncio (149808) Datos registrales: T 23873 , F 56, S 8, H M 412233, I/A 66 (20.03.13).

  • Cambio de domicilio social

    PLAZA DE LAS CORTES 8 (MADRID).

01/04/2013 Detalles del anuncio (149809) Datos registrales: T 23873 , F 56, S 8, H M 412233, I/A 67 (20.03.13).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 18.750.485,04 Euros. Resultante Suscrito: 16.933.310,24 Euros.

21/02/2013 Detalles del anuncio (87738) Datos registrales: T 23873 , F 55, S 8, H M 412233, I/A 65 (13.02.13).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: SERRAT MESEGAR FRANCISCO ANTONIO. Vicepresid.: SERRAT MESEGAR FRANCISCO ANTONIO. Con.Delegado: SERRAT MESEGAR FRANCISCO ANTONIO.

04/02/2013 Detalles del anuncio (54744) Datos registrales: T 23873 , F 55, S 8, H M 412233, I/A 64 (28.01.13).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: UZEL DOMINIQUE JEAN MARIE. Vicepresid.: UZEL DOMINIQUE JEAN MARIE. Con.Delegado: UZEL DOMINIQUE JEAN MARIE.

  • Nombramientos

    Consejero: SERRAT MESEGAR FRANCISCO ANTONIO. Vicepresid.: SERRAT MESEGAR FRANCISCO ANTONIO. Con.Delegado: SERRAT MESEGAR FRANCISCO ANTONIO.

08/11/2012 Detalles del anuncio (459714) Datos registrales: T 23873 , F 55, S 8, H M 412233, I/A 63 (26.10.12).

  • Ceses/Dimisiones

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

  • Nombramientos

    Auditor: DELOITTE SL.

30/10/2012 Detalles del anuncio (444053) Datos registrales: T 23873 , F 54, S 8, H M 412233, I/A 62 (18.10.12).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: LEON MARIE GHISLAIN LEFEVRE PIERRE PAUL JOSEPH. Presidente: LEON MARIE GHISLAIN LEFEVRE PIERRE PAUL JOSEPH.

  • Nombramientos

    Presidente: HILLAIRE FLORENT LOUIS JEAN.

  • Modificaciones Estatutarias

    ARTICULO 16º.COMPOSICION DEL CONSEJO.MODIFICADO.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 36

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2014-134-28 17/07/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2013-123-28 02/07/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-123-28 02/07/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-94-28 22/05/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-60-28 01/04/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-60-28 01/04/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-36-28 21/02/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-23-28 04/02/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2012-215-28 08/11/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-209-28 30/10/2012 Madrid Descargar