CHAMONIX SL

Extinta

C/ CASTELAO 2 - POLIGONO INDUSTRIAL GUADALHORCE, L (MALAGA).
Málaga
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 31/03/2023

GREGORIO ARJONA PINTO

Apoderado solidario
Cese: 31/03/2023

ROSILLO REIN ISABEL

Apoderado solidario
Cese: 31/03/2023

FERNANDEZ CAMPOS MARIA

Apoderado solidario
Nombramiento: 20/01/2023

DE TORRES ATENCIA BORJA

Apoderado
Cese: 20/01/2023

LUDOBOPA SL

Administrador único
Cese: 20/01/2023

DE TORRES ATENCIA BORJA

Apoderado
Cese: 20/01/2023

DE TORRES ATENCIA BORJA

Apoderado
Cese: 20/01/2023

DE TORRES ATENCIA PABLO

Apoderado
Cese: 20/01/2023

DE TORRES PEREZ DOMINGO

Apoderado
Cese: 20/01/2023

DE TORRES PEREZ DOMINGO

Apoderado
Cese: 20/01/2023

DE TORRES ATENCIA LOURDES ROSARIO

Apoderado
Cese: 20/01/2023

ALARCON LUQUE RICARDO ALVARO

Apoderado solidario
Cese: 20/01/2023

GREGORIO ARJONA PINTO

Apoderado solidario
Cese: 20/01/2023

ROSILLO REIN ISABEL

Apoderado solidario
Cese: 20/01/2023

FERNANDEZ CAMPOS MARIA

Apoderado solidario
Cese: 01/03/2022

GRANT THORNTON SLP

Auditor de cuentas consolidadas
Nombramiento: 17/11/2021

GRANT THORNTON SLP

Auditor de cuentas consolidadas
Nombramiento: 13/12/2018

GRANT THORNTON SLP

Auditor de cuentas consolidadas
Nombramiento: 23/05/2017

ALARCON LUQUE RICARDO ALVARO

Apoderado solidario
Nombramiento: 23/05/2017

GREGORIO ARJONA PINTO

Apoderado solidario
Nombramiento: 23/05/2017

ROSILLO REIN ISABEL

Apoderado solidario
Nombramiento: 23/05/2017

FERNANDEZ CAMPOS MARIA

Apoderado solidario
Nombramiento: 13/04/2016

DE TORRES PEREZ DOMINGO

Apoderado
Nombramiento: 13/04/2016

DE TORRES ATENCIA LOURDES ROSARIO

Apoderado
Cese: 24/02/2016

DE TORRES PEREZ DOMINGO

Consejero
Cese: 24/02/2016

DE TORRES PEREZ DOMINGO

Presidente
Cese: 24/02/2016

DE TORRES ATENCIA BORJA

Consejero
Cese: 24/02/2016

DE TORRES ATENCIA BORJA

Vicepresidente
Cese: 24/02/2016

DE TORRES PEREZ DOMINGO

Consejero delegado solidario
Cese: 24/02/2016

DE TORRES ATENCIA BORJA

Consejero delegado solidario
Cese: 24/02/2016

DE TORRES ATENCIA PABLO

Consejero
Cese: 24/02/2016

ATENCIA GARCIA MARIA SOLEDAD

Consejero
Cese: 24/02/2016

GONZALEZ RUBIO ANGEL

Consejero
Nombramiento: 24/02/2016

LUDOBOPA SL

Administrador único

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por CHAMONIX SL

31/03/2023 Detalles del anuncio (158999) Datos registrales: T 6259, L 5167, F 167, S 8, H MA 56729, I/A 27 (22.03.23).

  • Revocaciones

    Apo.Sol.: GREGORIO ARJONA PINTO;ROSILLO REIN ISABEL;FERNANDEZ CAMPOS MARIA.

20/01/2023 Detalles del anuncio (33684) Datos registrales: T 6259, L 5167, F 166, S 8, H MA 56729, I/A 26 ( 9.01.23).

  • Nombramientos

    Apoderado: DE TORRES ATENCIA BORJA.

20/01/2023 Detalles del anuncio (33682) Datos registrales: T 5597, L 4504, F 160, S 8, H MA 10510, I/A 33 ( 9.01.23).

  • Pérdida del carácter de unipersonalidad

    Ceses/Dimisiones.

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: LUDOBOPA SL.

  • Revocaciones

    Apoderado: DE TORRES ATENCIA BORJA;DE TORRES ATENCIA BORJA;DE TORRES ATENCIA PABLO;DE TORRES PEREZ DOMINGO;DE TORRES PEREZ DOMINGO;DE TORRES ATENCIA LOURDES ROSARIO. Apo.Sol.: ALARCON LUQUE RICARDO ALVARO;GREGORIO ARJONA PINTO;ROSILLO REIN ISABEL;FERNANDEZ CAMPOS MARIA.

  • Disolución

    Fusion.

  • Extinción

01/03/2022 Detalles del anuncio (91512) Datos registrales: T 5597, L 4504, F 160, S 8, H MA 10510, I/A 32 (16.02.22).

  • Revocaciones

    Aud.C.Con.: GRANT THORNTON SLP.

17/11/2021 Detalles del anuncio (500250) Datos registrales: T 5597, L 4504, F 160, S 8, H MA 10510, I/A 31 ( 9.11.21).

  • Nombramientos

    Aud.C.Con.: GRANT THORNTON SLP.

13/12/2018 Detalles del anuncio (499797) Datos registrales: T 5597, L 4504, F 159, S 8, H MA 10510, I/A 30 ( 4.12.18).

  • Nombramientos

    Aud.C.Con.: GRANT THORNTON SLP.

23/05/2017 Detalles del anuncio (213366) Datos registrales: T 5597, L 4504, F 159, S 8, H MA 10510, I/A 29 (12.05.17).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: ALARCON LUQUE RICARDO ALVARO;GREGORIO ARJONA PINTO;ROSILLO REIN ISABEL;FERNANDEZ CAMPOS MARIA.

09/03/2017 Detalles del anuncio (111747) Datos registrales: T 4922, L 3830, F 70, S 8, H MA 10510, I/A 28 (24.02.17).

  • Fusión por Absorción

    Sociedades absorbidas: FRIALDIS SL. FRIO PANDION SL.

22/02/2017 Detalles del anuncio (87317) Datos registrales: T 4922, L 3830, F 70, S 8, H MA 10510, I/A 27 (10.02.17).

  • Declaración de unipersonalidad. Socio Único.

    LUDOBOPA SL.

13/04/2016 Detalles del anuncio (162099) Datos registrales: T 4922, L 3830, F 69, S 8, H MA 10510, I/A 25 ( 1.04.16).

  • Nombramientos

    Apoderado: DE TORRES PEREZ DOMINGO.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 29

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2023-63-29 31/03/2023 Málaga Descargar
BORME-A-2023-14-29 20/01/2023 Málaga Descargar
BORME-A-2023-14-29 20/01/2023 Málaga Descargar
BORME-A-2022-41-29 01/03/2022 Málaga Descargar
BORME-A-2021-220-29 17/11/2021 Málaga Descargar
BORME-A-2018-238-29 13/12/2018 Málaga Descargar
BORME-A-2017-95-29 23/05/2017 Málaga Descargar
BORME-A-2017-48-29 09/03/2017 Málaga Descargar
BORME-A-2017-37-29 22/02/2017 Málaga Descargar
BORME-A-2016-70-29 13/04/2016 Málaga Descargar