CAHISPA DE SEGUROS GENERALES SA

Cambio de denominación social

Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 27/10/2011

OBON RIBO SERGI

Apoderado
Nombramiento: 27/10/2011

CASTELLA CABALLE JAVIER

Apoderado
Nombramiento: 17/08/2011

CORBIS PORTFOLIO ASSETS SL

Administrador único
Nombramiento: 17/08/2011

PINTO CUENCA FRANCISCO JAVIER

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 17/08/2011

LAVILLA SANCHEZ FERNANDO

Administrador solidario
Nombramiento: 17/08/2011

OBON RIBO SERGI

Apoderado
Nombramiento: 17/08/2011

CASTELLA CABALLE JAVIER

Apoderado
Nombramiento: 15/03/2011

ERNST & YOUNG SL

Auditor de cuentas
Cese: 29/04/2010

GUILLO VIVE ARTURO

Consejero
Cese: 29/04/2010

GUILLO VIVE ARTURO

Presidente
Cese: 29/04/2010

MUÑOZ DE MIGUEL JOAQUIN

Consejero
Cese: 29/04/2010

MUÑOZ DE MIGUEL JOAQUIN

Vicepresidente
Cese: 29/04/2010

MUÑOZ DE MIGUEL JOAQUIN

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 29/04/2010

MUÑOZ DE MIGUEL CONCEPCION

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 29/04/2010

MUÑOZ DE MIGUEL MARIA ISABEL

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 29/04/2010

GUILLO VIVE ARTURO

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 29/04/2010

GUILLO VIVE ARTURO

Consejero delegado
Cese: 08/02/2010

CRISTOBAL VIVES MONTSERRAT

Apoderado
Cese: 08/02/2010

SANTISO LOREN MARIA FRANCISCA

Apoderado
Cese: 08/02/2010

MUÑOZ DE MIGUEL JOAQUIN

Apoderado
Cese: 08/02/2010

BERGE NAVALON JAIME

Apoderado
Cese: 08/02/2010

ARAN TORRES MANUEL

Apoderado
Cese: 08/02/2010

GINER ARGUETA JUAN

Apoderado
Cese: 08/02/2010

REIG NAVALON JORGE

Apoderado
Cese: 08/02/2010

SORIANO CUSSO DANIEL

Apoderado
Cese: 08/02/2010

BERGE NAVALON JAIME

Consejero
Cese: 14/12/2009

GAGO RODRIGUEZ SERGIO

Administrador solidario

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por CAHISPA DE SEGUROS GENERALES SA

09/05/2014 Detalles del anuncio (731)

  • Cancelaciones de Depósitos de proyectos de fusión por absorción

    Absorbidas: PROYECTO EMPRESARIAL ALCE SL; PREDIUM BARCELONA SL; TOP MIRANDA SL; NOCEDIXIT SL; TINDAYA SOL SL.

16/02/2012 Detalles del anuncio (77175) Datos registrales: T 42838 , F 31, S 8, H B 48144, I/A 148 ( 6.02.12).

  • Cambio de denominación social

    CAHISPA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS GENERALES.

  • Cambio de objeto social

    AMPLIAR A:LA PRACTICA DE OPERACIONES DE REASEGURO.

27/10/2011 Detalles del anuncio (425649) Datos registrales: T 37206 , F 110, S 8, H B 48144, I/A 147 (18.10.11).

  • Nombramientos

    APODERADO: OBON RIBO SERGI;CASTELLA CABALLE JAVIER.

17/08/2011 Detalles del anuncio (340234) Datos registrales: T 37206 , F 108, S 8, H B 48144, I/A 144 ( 5.08.11).

  • Nombramientos

    ADM.UNICO: CORBIS PORTFOLIO ASSETS SL. REPR.143 RRM: PINTO CUENCA FRANCISCO JAVIER.

  • Modificaciones Estatutarias

    ARTS.8,14,16,20,23,26,28,29,31,34 Y DISPOSICION FINAL.-MODIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL.

17/08/2011 Detalles del anuncio (340465) Datos registrales: T 37206 , F 110, S 8, H B 48144, I/A 145 ( 5.08.11).

  • Revocaciones

    ADM.SOLIDAR.: LAVILLA SANCHEZ FERNANDO.

17/08/2011 Detalles del anuncio (340236) Datos registrales: T 37206 , F 110, S 8, H B 48144, I/A 146 ( 5.08.11).

  • Nombramientos

    APODERADO: OBON RIBO SERGI;CASTELLA CABALLE JAVIER.

15/07/2011 Detalles del anuncio (210020)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Junio de 2011) Año: 2010

15/03/2011 Detalles del anuncio (116220) Datos registrales: T 37206 , F 108, S 8, H B 48144, I/A 143 ( 3.03.11).

  • Nombramientos

    AUDIT.CUENT.: ERNST & YOUNG SL.

29/10/2010 Detalles del anuncio (920489)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Septiembre de 2010) Año: 2009

18/08/2010 Detalles del anuncio (323007) Datos registrales: T 37206 , F 107, S 8, H B 48144, I/A 141 (15.04.10).

  • Fe de erratas

    En el BORME no.80/2010 y con referencia 172660 NO DEBEN LEERSE LAS REVOCACIONES DE LAS SRAS.CONCEPCION E ISABEL MUÑOZ DE MIGUEL,Y EN SU LUGAR DEBE LEERSE:SANCION DIR.GRAL.SEGUROS DE 18/12/08,FIRME EL 28/4/09,SUSPENSION TEMPORAL EN EL EJERCICIO DEL CARGO POR PERIODO 12 AÑOS.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 18

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-B-2014-87-08 09/05/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2012-33-08 16/02/2012 Barcelona Descargar
BORME-A-2011-205-08 27/10/2011 Barcelona Descargar
BORME-A-2011-156-08 17/08/2011 Barcelona Descargar
BORME-A-2011-156-08 17/08/2011 Barcelona Descargar
BORME-A-2011-156-08 17/08/2011 Barcelona Descargar
BORME-B-2011-135-08 15/07/2011 Barcelona Descargar
BORME-A-2011-51-08 15/03/2011 Barcelona Descargar
BORME-B-2010-209-08 29/10/2010 Barcelona Descargar
BORME-A-2010-158-08 18/08/2010 Barcelona Descargar