BARCEL EURO GESTION SL

Cambio de denominación social

AV DIAGONAL Num.477 P.18 (BARCELONA).
Barcelona
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 19/08/2009

MACIA SARMIENTO JOSE LUIS

Consejero
Cese: 19/08/2009

VIDAL RIUS ANTONIO

Consejero
Cese: 22/05/2009

BARBEITO FERNANDEZ EDUARDO

Consejero
Cese: 22/05/2009

BARBEITO FERNANDEZ EDUARDO

Vicepresidente segundo
Cese: 22/05/2009

ERROZ ESPARZA CARLOS

Consejero
Cese: 22/05/2009

GRACIA SILVESTRE JORGE

Apoderado
Cese: 22/05/2009

AMAT BADRINAS XAVIER

Apoderado
Nombramiento: 22/05/2009

PERALTA LECHUGA FERNANDO

Apoderado
Nombramiento: 03/04/2009

ERNST AND YOUNG SL

Auditor de cuentas
Cese: 04/03/2009

ERROZ BELTRAN JUAN BAUTISTA

Apoderado
Nombramiento: 04/03/2009

TORREBLANCA RAMIREZ MANUEL

Apoderado
Nombramiento: 04/03/2009

GRACIA SILVESTRE JORGE

Apoderado
Nombramiento: 04/03/2009

AMAT BADRINAS XAVIER

Apoderado

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por BARCEL EURO GESTION SL

01/02/2010 Detalles del anuncio (40051) Datos registrales: T 41393 , F 121, S 8, H B 314032, I/A 10 (19.01.10).

  • Cambio de denominación social

    MINERVA SERVICIOS INTEGRADOS SL.

19/08/2009 Detalles del anuncio (362611) Datos registrales: T 41393 , F 121, S 8, H B 314032, I/A 9 ( 7.08.09).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: MACIA SARMIENTO JOSE LUIS;VIDAL RIUS ANTONIO.

25/06/2009 Detalles del anuncio (286485) Datos registrales: T 40262 , F 68, S 8, H B 314032, I/A 8 (11.06.09).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 2.300.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 20.300.000,00 Euros.

22/05/2009 Detalles del anuncio (232935) Datos registrales: T 40262 , F 67, S 8, H B 314032, I/A 7 (11.05.09).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: BARBEITO FERNANDEZ EDUARDO. VICEPRESID.2: BARBEITO FERNANDEZ EDUARDO. CONSEJERO: ERROZ ESPARZA CARLOS. APODERADO: GRACIA SILVESTRE JORGE;AMAT BADRINAS XAVIER.

  • Nombramientos

    APODERADO: PERALTA LECHUGA FERNANDO.

03/04/2009 Detalles del anuncio (163770) Datos registrales: T 40262 , F 67, S 8, H B 314032, I/A 6 (23.03.09).

  • Nombramientos

    AUDIT.CUENT.: ERNST AND YOUNG SL.

04/03/2009 Detalles del anuncio (111409) Datos registrales: T 40262 , F 65, S 8, H B 314032, I/A 5 (20.02.09).

  • Revocaciones

    APODERADO: ERROZ BELTRAN JUAN BAUTISTA.

  • Nombramientos

    APODERADO: TORREBLANCA RAMIREZ MANUEL;GRACIA SILVESTRE JORGE;AMAT BADRINAS XAVIER.

10/02/2009 Detalles del anuncio (70931) Datos registrales: T 40262 , F 65, S 8, H B 314032, I/A 4 (29.01.09).

  • Cambio de domicilio social

    AV DIAGONAL Num.477 P.18 (BARCELONA).

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 7

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2010-20-08 01/02/2010 Barcelona Descargar
BORME-A-2009-157-08 19/08/2009 Barcelona Descargar
BORME-A-2009-118-08 25/06/2009 Barcelona Descargar
BORME-A-2009-95-08 22/05/2009 Barcelona Descargar
BORME-A-2009-64-08 03/04/2009 Barcelona Descargar
BORME-A-2009-43-08 04/03/2009 Barcelona Descargar
BORME-A-2009-27-08 10/02/2009 Barcelona Descargar