ARGUIS GESTION INMOBILIARIA SL
Extinta
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
|
Fecha
|
Nombre
|
|
|---|---|---|
| Cese: 01/09/2014 | TAGACORP SOCIEDAD LIMITADA |
Administrador único |
| Cese: 01/09/2014 | VILLARROYA LORAN PEDRO |
Apoderado solidario |
| Cese: 01/09/2014 | TABUENCA GALLARDO PABLO |
Apoderado mancomunado solidario |
| Cese: 01/09/2014 | TABUENCA GALLARDO JOSE CARLOS |
Apoderado mancomunado solidario |
| Cese: 01/09/2014 | VILLACAMPA RUBIO JESUS |
Apoderado |
| Nombramiento: 01/09/2014 | TAGACORP SOCIEDAD LIMITADA |
Liquidador |
| Cese: 25/03/2014 | PASTOR VAL GREGORIO |
Apoderado solidario |
| Cese: 05/07/2013 | TORRALBA GOMEZ JOSE LUIS |
Apoderado solidario |
| Cese: 05/07/2013 | ARTAL CLAVERO ANGEL |
Apoderado solidario |
| Cese: 05/07/2013 | ARIÑO ALEGRE ALBERTO |
Apoderado solidario |
| Cese: 19/10/2012 | JAEN JULIAN FERNANDO |
Apoderado solidario |
| Cese: 27/07/2012 | FRON CUBERO JOSE MIGUEL |
Apoderado solidario |
| Cese: 27/07/2012 | GARATE PEREZ JUAN MARIA |
Apoderado solidario |
| Nombramiento: 27/07/2012 | VILLACAMPA RUBIO JESUS |
Apoderado |
| Cese: 05/07/2012 | SALINAS LIZANA ANGEL |
Apoderado solidario |
| Cese: 26/05/2009 | PEREZ CHAVARRIA JOSE JONATAN |
Apoderado solidario |
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por ARGUIS GESTION INMOBILIARIA SL
01/09/2014 Detalles del anuncio (351736) Datos registrales: T 3179 , F 43, S 8, H Z 31397, I/A 17 (21.08.14).
- Ceses/Dimisiones
Adm. Unico: TAGACORP SOCIEDAD LIMITADA.
- Revocaciones
Apo.Sol.: VILLARROYA LORAN PEDRO. Apo.Man.Soli: TABUENCA GALLARDO PABLO;TABUENCA GALLARDO JOSE CARLOS. Apoderado: VILLACAMPA RUBIO JESUS.
- Nombramientos
Liquidador: TAGACORP SOCIEDAD LIMITADA.
- Disolución
Voluntaria.
- Extinción
25/03/2014 Detalles del anuncio (134600) Datos registrales: T 3179 , F 43, S 8, H Z 31397, I/A 16 (13.03.14).
- Revocaciones
Apo.Sol.: PASTOR VAL GREGORIO.
05/07/2013 Detalles del anuncio (308154) Datos registrales: T 3179 , F 43, S 8, H Z 31397, I/A 15 (21.06.13).
- Revocaciones
Apo.Sol.: TORRALBA GOMEZ JOSE LUIS;ARTAL CLAVERO ANGEL;ARIÑO ALEGRE ALBERTO.
19/10/2012 Detalles del anuncio (427163) Datos registrales: T 3179 , F 43, S 8, H Z 31397, I/A 14 ( 5.10.12).
- Revocaciones
Apo.Sol.: JAEN JULIAN FERNANDO.
27/07/2012 Detalles del anuncio (318453) Datos registrales: T 3179 , F 42, S 8, H Z 31397, I/A 12 (17.07.12).
- Revocaciones
Apo.Sol.: FRON CUBERO JOSE MIGUEL.
27/07/2012 Detalles del anuncio (318452) Datos registrales: T 3179 , F 42, S 8, H Z 31397, I/A 11 (17.07.12).
- Revocaciones
Apo.Sol.: GARATE PEREZ JUAN MARIA.
27/07/2012 Detalles del anuncio (318454) Datos registrales: T 3179 , F 42, S 8, H Z 31397, I/A 13 (17.07.12).
- Nombramientos
Apoderado: VILLACAMPA RUBIO JESUS.
05/07/2012 Detalles del anuncio (285150) Datos registrales: T 3179 , F 42, S 8, H Z 31397, I/A 10 (26.06.12).
- Revocaciones
Apo.Sol.: SALINAS LIZANA ANGEL.
21/09/2011 Detalles del anuncio (577869)
- Depósitos de cuentas anuales
(Septiembre de 2011) Año: 2010
20/09/2010 Detalles del anuncio (590798)
- Depósitos de cuentas anuales
(Septiembre de 2010) Año: 2009
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 12
|
#CVE
|
Fecha
|
Provincia
|
|
|---|---|---|---|
| BORME-A-2014-165-50 | 01/09/2014 | Zaragoza | Descargar |
| BORME-A-2014-58-50 | 25/03/2014 | Zaragoza | Descargar |
| BORME-A-2013-126-50 | 05/07/2013 | Zaragoza | Descargar |
| BORME-A-2012-202-50 | 19/10/2012 | Zaragoza | Descargar |
| BORME-A-2012-143-50 | 27/07/2012 | Zaragoza | Descargar |
| BORME-A-2012-143-50 | 27/07/2012 | Zaragoza | Descargar |
| BORME-A-2012-143-50 | 27/07/2012 | Zaragoza | Descargar |
| BORME-A-2012-127-50 | 05/07/2012 | Zaragoza | Descargar |
| BORME-B-2011-180-50 | 21/09/2011 | Zaragoza | Descargar |
| BORME-B-2010-181-50 | 20/09/2010 | Zaragoza | Descargar |