ARGUIS GESTION INMOBILIARIA SL

Extinta

Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 01/09/2014

TAGACORP SOCIEDAD LIMITADA

Administrador único
Cese: 01/09/2014

VILLARROYA LORAN PEDRO

Apoderado solidario
Cese: 01/09/2014

TABUENCA GALLARDO PABLO

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 01/09/2014

TABUENCA GALLARDO JOSE CARLOS

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 01/09/2014

VILLACAMPA RUBIO JESUS

Apoderado
Nombramiento: 01/09/2014

TAGACORP SOCIEDAD LIMITADA

Liquidador
Cese: 25/03/2014

PASTOR VAL GREGORIO

Apoderado solidario
Cese: 05/07/2013

TORRALBA GOMEZ JOSE LUIS

Apoderado solidario
Cese: 05/07/2013

ARTAL CLAVERO ANGEL

Apoderado solidario
Cese: 05/07/2013

ARIÑO ALEGRE ALBERTO

Apoderado solidario
Cese: 19/10/2012

JAEN JULIAN FERNANDO

Apoderado solidario
Cese: 27/07/2012

FRON CUBERO JOSE MIGUEL

Apoderado solidario
Cese: 27/07/2012

GARATE PEREZ JUAN MARIA

Apoderado solidario
Nombramiento: 27/07/2012

VILLACAMPA RUBIO JESUS

Apoderado
Cese: 05/07/2012

SALINAS LIZANA ANGEL

Apoderado solidario
Cese: 26/05/2009

PEREZ CHAVARRIA JOSE JONATAN

Apoderado solidario

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por ARGUIS GESTION INMOBILIARIA SL

01/09/2014 Detalles del anuncio (351736) Datos registrales: T 3179 , F 43, S 8, H Z 31397, I/A 17 (21.08.14).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: TAGACORP SOCIEDAD LIMITADA.

  • Revocaciones

    Apo.Sol.: VILLARROYA LORAN PEDRO. Apo.Man.Soli: TABUENCA GALLARDO PABLO;TABUENCA GALLARDO JOSE CARLOS. Apoderado: VILLACAMPA RUBIO JESUS.

  • Nombramientos

    Liquidador: TAGACORP SOCIEDAD LIMITADA.

  • Disolución

    Voluntaria.

  • Extinción

25/03/2014 Detalles del anuncio (134600) Datos registrales: T 3179 , F 43, S 8, H Z 31397, I/A 16 (13.03.14).

  • Revocaciones

    Apo.Sol.: PASTOR VAL GREGORIO.

05/07/2013 Detalles del anuncio (308154) Datos registrales: T 3179 , F 43, S 8, H Z 31397, I/A 15 (21.06.13).

  • Revocaciones

    Apo.Sol.: TORRALBA GOMEZ JOSE LUIS;ARTAL CLAVERO ANGEL;ARIÑO ALEGRE ALBERTO.

19/10/2012 Detalles del anuncio (427163) Datos registrales: T 3179 , F 43, S 8, H Z 31397, I/A 14 ( 5.10.12).

  • Revocaciones

    Apo.Sol.: JAEN JULIAN FERNANDO.

27/07/2012 Detalles del anuncio (318453) Datos registrales: T 3179 , F 42, S 8, H Z 31397, I/A 12 (17.07.12).

  • Revocaciones

    Apo.Sol.: FRON CUBERO JOSE MIGUEL.

27/07/2012 Detalles del anuncio (318452) Datos registrales: T 3179 , F 42, S 8, H Z 31397, I/A 11 (17.07.12).

  • Revocaciones

    Apo.Sol.: GARATE PEREZ JUAN MARIA.

27/07/2012 Detalles del anuncio (318454) Datos registrales: T 3179 , F 42, S 8, H Z 31397, I/A 13 (17.07.12).

  • Nombramientos

    Apoderado: VILLACAMPA RUBIO JESUS.

05/07/2012 Detalles del anuncio (285150) Datos registrales: T 3179 , F 42, S 8, H Z 31397, I/A 10 (26.06.12).

  • Revocaciones

    Apo.Sol.: SALINAS LIZANA ANGEL.

21/09/2011 Detalles del anuncio (577869)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Septiembre de 2011) Año: 2010

20/09/2010 Detalles del anuncio (590798)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Septiembre de 2010) Año: 2009

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 12

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2014-165-50 01/09/2014 Zaragoza Descargar
BORME-A-2014-58-50 25/03/2014 Zaragoza Descargar
BORME-A-2013-126-50 05/07/2013 Zaragoza Descargar
BORME-A-2012-202-50 19/10/2012 Zaragoza Descargar
BORME-A-2012-143-50 27/07/2012 Zaragoza Descargar
BORME-A-2012-143-50 27/07/2012 Zaragoza Descargar
BORME-A-2012-143-50 27/07/2012 Zaragoza Descargar
BORME-A-2012-127-50 05/07/2012 Zaragoza Descargar
BORME-B-2011-180-50 21/09/2011 Zaragoza Descargar
BORME-B-2010-181-50 20/09/2010 Zaragoza Descargar