APARCAMIENTO ATOCHA 70 SL

Cambio de denominación social

CMNO DE LAS CEUDAS 2 1º (ROZAS DE MADRID (LAS)).
 Rozas de Madrid, Las, Madrid
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 02/10/2019

JIMENEZ GUMIEL FRANCISCO JAVIER

Administrador único
Nombramiento: 02/10/2019

IPARK ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS DE MOVILIDAD SA

Administrador único
Nombramiento: 02/10/2019

MOGARRA GONZALEZ JUAN MANUEL

Representante
Cese: 22/03/2016

CORDOBA POZO JUAN MANUEL

Administrador único
Nombramiento: 22/03/2016

JIMENEZ GUMIEL FRANCISCO JAVIER

Administrador único
Cese: 25/01/2016

SANTOS DUTREY JUAN CARLOS

Apoderado
Cese: 25/01/2016

MEJIAS VILLATORO PEDRO JOSE

Apoderado
Cese: 03/07/2014

MEJIAS VILLATORO PEDRO JOSE

Secretario
Cese: 03/07/2014

SANTOS DUTREY JUAN CARLOS

Representante
Cese: 03/07/2014

CARBONELL CARBONELL FRANCISCA

Representante
Cese: 03/07/2014

CENTRO DE AGENTES UNIDOS DEL CALZADO ESPAÑOL SL

Consejero
Cese: 03/07/2014

BLASCONELL SL

Consejero
Cese: 03/07/2014

FRANCO MARTINEZ-BORDIU FRANCISCO

Consejero
Cese: 03/07/2014

CENTRO DE AGENTES UNIDOS DEL CALZADO ESPAÑOL SL

Presidente
Cese: 03/07/2014

CENTRO DE AGENTES UNIDOS DEL CALZADO ESPAÑOL SL

Consejero delegado solidario
Cese: 03/07/2014

FRANCO MARTINEZ-BORDIU FRANCISCO

Consejero delegado solidario
Nombramiento: 03/07/2014

CORDOBA POZO JUAN MANUEL

Administrador único

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por APARCAMIENTO ATOCHA 70 SL

18/05/2022 Detalles del anuncio (220677) Datos registrales: T 22708 , F 213, S 8, H M 115601, I/A 19 (10.05.22).

  • Cambio de denominación social

    PARKINGS PICO DE LA ESPERANZA SL.

02/10/2019 Detalles del anuncio (409222) Datos registrales: T 22708 , F 212, S 8, H M 115601, I/A 18 (25.09.19).

  • Declaración de unipersonalidad. Socio Único.

    IPARK ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS DE MOVILIDAD SA.

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: JIMENEZ GUMIEL FRANCISCO JAVIER.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: IPARK ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS DE MOVILIDAD SA. Representan: MOGARRA GONZALEZ JUAN MANUEL.

  • Cambio de domicilio social

    CMNO DE LAS CEUDAS 2 1º (ROZAS DE MADRID (LAS)).

19/08/2019 Detalles del anuncio (360023) Datos registrales: T 22708 , F 211, S 8, H M 115601, I/A 17 ( 9.08.19).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 112.329,75 Euros. Resultante Suscrito: 40.073,38 Euros.

27/11/2018 Detalles del anuncio (473569) Datos registrales: T 22708 , F 211, S 8, H M 115601, I/A 16 (20.11.18).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 86.298,41 Euros. Resultante Suscrito: 152.403,13 Euros.

22/03/2016 Detalles del anuncio (132086) Datos registrales: T 22708 , F 211, S 8, H M 115601, I/A 15 (15.03.16).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: CORDOBA POZO JUAN MANUEL.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: JIMENEZ GUMIEL FRANCISCO JAVIER.

25/01/2016 Detalles del anuncio (29726) Datos registrales: T 22708 , F 210, S 8, H M 115601, I/A 14 (15.01.16).

  • Revocaciones

    Apoderado: SANTOS DUTREY JUAN CARLOS;MEJIAS VILLATORO PEDRO JOSE.

03/07/2014 Detalles del anuncio (275675) Datos registrales: T 22708 , F 210, S 8, H M 115601, I/A 13 (26.06.14).

  • Ceses/Dimisiones

    Secretario: MEJIAS VILLATORO PEDRO JOSE. Representan: SANTOS DUTREY JUAN CARLOS;CARBONELL CARBONELL FRANCISCA. Consejero: CENTRO DE AGENTES UNIDOS DEL CALZADO ESPAÑOL SL;BLASCONELL SL;FRANCO MARTINEZ-BORDIU FRANCISCO. Presidente: CENTRO DE AGENTES UNIDOS DEL CALZADO ESPAÑOL SL. Cons.Del.Sol: CENTRO DE AGENTES UNIDOS DEL CALZADO ESPAÑOL SL;FRANCO MARTINEZ-BORDIU FRANCISCO

  • Nombramientos

    Adm. Unico: CORDOBA POZO JUAN MANUEL.

  • Modificaciones Estatutarias

    Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.

  • Cambio de domicilio social

    C/ AYALA 7 - BAJO (MADRID).

14/09/2011 Detalles del anuncio (519934)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Agosto de 2011) Año: 2009

14/09/2011 Detalles del anuncio (519748)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Agosto de 2011) Año: 2008

06/08/2009 Detalles del anuncio (190980)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Julio de 2009) Año: 2007

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 10

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2022-93-28 18/05/2022 Madrid Descargar
BORME-A-2019-189-28 02/10/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2019-157-28 19/08/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2018-227-28 27/11/2018 Madrid Descargar
BORME-A-2016-56-28 22/03/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2016-15-28 25/01/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2014-124-28 03/07/2014 Madrid Descargar
BORME-B-2011-175-28 14/09/2011 Madrid Descargar
BORME-B-2011-175-28 14/09/2011 Madrid Descargar
BORME-B-2009-148-28 06/08/2009 Madrid Descargar