ANDROID INDUSTRIES ZARAGOZA SL

Extinta

POLIG INDUSTRIAL ENTERRIOS S/N (FIGUERUELAS).
 Figueruelas, Zaragoza  (50639)
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 16/11/2021

NICHOLS GREGORY LOUIS

Consejero
Cese: 16/11/2021

NICHOLS GREGORY LOUIS

Consejero delegado
Cese: 16/11/2021

NICHOLS GREGORY LOUIS

Secretario
Cese: 16/11/2021

NIAZY NICHOLS KATHRYN

Consejero
Cese: 16/11/2021

DE CLERCQ PATRICIA T

Consejero
Cese: 16/11/2021

NIAZY NICHOLS KATHRYN

Presidente
Cese: 16/11/2021

MODREGO IBAÑEZ ANGEL LUIS

Apoderado solidario
Cese: 16/11/2021

ROSALES VICENTE SIMON

Apoderado solidario
Cese: 16/11/2021

CAPISTROS HURTADO MARIA JOSE

Apoderado solidario
Cese: 16/11/2021

ROSALES VICENTE SIMON

Apoderado
Cese: 16/11/2021

CAPISTROS HURTADO MARIA JOSE

Apoderado
Cese: 16/11/2021

MORENO LUNA EDGARDO

Apoderado
Nombramiento: 16/11/2021

MODREGO IBAÑEZ ANGEL LUIS

Liquidador
Nombramiento: 14/06/2021

MORENO LUNA EDGARDO

Apoderado
Cese: 20/10/2020

HALLIDAY JILL LOUISE

Apoderado
Nombramiento: 20/10/2020

ROSALES VICENTE SIMON

Apoderado
Nombramiento: 20/10/2020

CAPISTROS HURTADO MARIA JOSE

Apoderado
Cese: 29/01/2020

NIAZY RAMSEY RICHARD

Consejero
Cese: 29/01/2020

MASSERANG KEITH MICHAEL

Consejero
Cese: 29/01/2020

NIAZY RAMSEY RICHARD

Presidente
Nombramiento: 29/01/2020

NIAZY NICHOLS KATHRYN

Consejero
Nombramiento: 29/01/2020

DE CLERCQ PATRICIA T

Consejero
Nombramiento: 29/01/2020

NIAZY NICHOLS KATHRYN

Presidente
Cese: 13/12/2019

MASSERANG KEITH MICHAEL

Secretario
Nombramiento: 13/12/2019

NICHOLS GREGORY LOUIS

Secretario
Nombramiento: 05/03/2019

MAZARS AUDITORES SLP

Auditor
Nombramiento: 05/03/2019

MAZARS AUDITORES SLP

Auditor de cuentas consolidadas
Cese: 16/02/2016

GARCIA SAPETTI RAMON

Apoderado
Nombramiento: 16/02/2016

HALLIDAY JILL LOUISE

Apoderado
Nombramiento: 27/01/2016

DELOITTE SL

Auditor
Nombramiento: 27/01/2016

DELOITTE SL

Auditor de cuentas consolidadas
Cese: 03/08/2015

CARCAS DE BENAVIDES JOSE-ANTONIO

Apoderado
Cese: 03/08/2015

CARCAS DE BENAVIDES JOSE-ANTONIO

Apoderado solidario
Cese: 03/08/2015

CARCAS DE BENAVIDES JOSE-ANTONIO

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 03/08/2015

CABOT SETO FRANCESC

Apoderado solidario
Cese: 03/08/2015

CALAVIA ARIAS JOSE MANUEL

Apoderado solidario
Cese: 03/08/2015

BOVER HIDIROGLU ANTONIO

Apoderado solidario
Cese: 03/08/2015

GUARINO ROBERT-CRAIG

Apoderado
Nombramiento: 03/08/2015

ROSALES VICENTE SIMON

Apoderado solidario
Nombramiento: 03/08/2015

CAPISTROS HURTADO MARIA JOSE

Apoderado solidario
Nombramiento: 22/06/2015

CARCAS DE BENAVIDES JOSE-ANTONIO

Apoderado solidario
Nombramiento: 22/06/2015

MODREGO IBAÑEZ ANGEL LUIS

Apoderado solidario
Nombramiento: 22/06/2015

ROSALES VICENTE SIMON

Apoderado solidario

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por ANDROID INDUSTRIES ZARAGOZA SL

16/11/2021 Detalles del anuncio (498398) Datos registrales: T 3765 , F 206, S 8, H Z 48928, I/A 26 ( 9.11.21).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: NICHOLS GREGORY LOUIS. Con.Delegado: NICHOLS GREGORY LOUIS. Secretario: NICHOLS GREGORY LOUIS. Consejero: NIAZY NICHOLS KATHRYN;DE CLERCQ PATRICIA T. Presidente: NIAZY NICHOLS KATHRYN.

  • Revocaciones

    Apo.Sol.: MODREGO IBAÑEZ ANGEL LUIS;ROSALES VICENTE SIMON;CAPISTROS HURTADO MARIA JOSE. Apoderado: ROSALES VICENTE SIMON;CAPISTROS HURTADO MARIA JOSE;MORENO LUNA EDGARDO.

  • Nombramientos

    Liquidador: MODREGO IBAÑEZ ANGEL LUIS.

  • Disolución

    Voluntaria.

  • Extinción

14/06/2021 Detalles del anuncio (288110) Datos registrales: T 3765 , F 206, S 8, H Z 48928, I/A 25 ( 7.06.21).

  • Nombramientos

    Apoderado: MORENO LUNA EDGARDO.

11/02/2021 Detalles del anuncio (67789) Datos registrales: T 3765 , F 205, S 8, H Z 48928, I/A 24 ( 4.02.21).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 2.485.410,00 Euros. Resultante Suscrito: 735.150,00 Euros.

20/10/2020 Detalles del anuncio (355533) Datos registrales: T 3765 , F 205, S 8, H Z 48928, I/A 23 ( 9.10.20).

  • Revocaciones

    Apoderado: HALLIDAY JILL LOUISE.

  • Nombramientos

    Apoderado: ROSALES VICENTE SIMON;CAPISTROS HURTADO MARIA JOSE.

29/01/2020 Detalles del anuncio (42274) Datos registrales: T 3765 , F 204, S 8, H Z 48928, I/A 22 (21.01.20).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: NIAZY RAMSEY RICHARD;MASSERANG KEITH MICHAEL. Presidente: NIAZY RAMSEY RICHARD.

  • Nombramientos

    Consejero: NIAZY NICHOLS KATHRYN;DE CLERCQ PATRICIA T. Presidente: NIAZY NICHOLS KATHRYN.

13/12/2019 Detalles del anuncio (516417) Datos registrales: T 3765 , F 204, S 8, H Z 48928, I/A 21 ( 4.12.19).

  • Ceses/Dimisiones

    Secretario: MASSERANG KEITH MICHAEL.

  • Nombramientos

    Secretario: NICHOLS GREGORY LOUIS.

05/03/2019 Detalles del anuncio (103065) Datos registrales: T 3765 , F 204, S 8, H Z 48928, I/A 20 (25.02.19).

  • Nombramientos

    Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: MAZARS AUDITORES SLP.

27/02/2017 Detalles del anuncio (94986) Datos registrales: T 3765 , F 204, S 8, H Z 48928, I/A 19 (17.02.17).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 750.090,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.220.560,00 Euros.

02/11/2016 Detalles del anuncio (441820) Datos registrales: T 3765 , F 203, S 8, H Z 48928, I/A 18 (21.10.16).

  • Cambio de objeto social

    1. La prestación de cualquier tipo de servicios de secuenciación, montaje, almacenamiento y cualquier servicio afín para la industria del automóvil o cualquier otro tipo de industria. 2. Comprar, suscribir, permutar y vender toda clase de valores mobiliarios, nacionales y extranjeros, cualquiera que.

04/03/2016 Detalles del anuncio (104649) Datos registrales: T 3765 , F 203, S 8, H Z 48928, I/A 16 (26.02.16).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 599.360,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.876.470,00 Euros.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 29

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2021-219-50 16/11/2021 Zaragoza Descargar
BORME-A-2021-111-50 14/06/2021 Zaragoza Descargar
BORME-A-2021-28-50 11/02/2021 Zaragoza Descargar
BORME-A-2020-203-50 20/10/2020 Zaragoza Descargar
BORME-A-2020-19-50 29/01/2020 Zaragoza Descargar
BORME-A-2019-238-50 13/12/2019 Zaragoza Descargar
BORME-A-2019-44-50 05/03/2019 Zaragoza Descargar
BORME-A-2017-40-50 27/02/2017 Zaragoza Descargar
BORME-A-2016-209-50 02/11/2016 Zaragoza Descargar
BORME-A-2016-44-50 04/03/2016 Zaragoza Descargar