AHORRO CORPORACION DESARROLLO SGECR SA

Cambio de denominación social

Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 21/10/2015

GIMENEZ-ARRIBAS GORDILLO LUIS

Secretario no consejero
Cese: 21/10/2015

RIVILLA CALLE BLANCA

Consejero
Cese: 21/10/2015

RIVILLA CALLE BLANCA

Presidente
Cese: 21/10/2015

GIL GAGO JOSE ANTONIO

Consejero
Cese: 21/10/2015

SANCHEZ DEL VILLAR BOCETA ENRIQUE

Consejero
Nombramiento: 21/10/2015

GONZALEZ DE LUNA IÑIGO

Consejero
Nombramiento: 21/10/2015

GONZALEZ DE LUNA IÑIGO

Presidente
Nombramiento: 21/10/2015

SANCHEZ DEL RIO Y PRECIOSO MARIA ABIGAIL

Consejero
Nombramiento: 21/10/2015

SANCHEZ DEL RIO Y PRECIOSO MARIA ABIGAIL

Secretario
Nombramiento: 21/10/2015

CHICHARRO ORTEGA LUIS

Consejero
Nombramiento: 21/10/2015

GONZALEZ DE LUNA IÑIGO

Consejero delegado
Cese: 31/08/2015

TOUBES TORRES PALOMA GUADALUPE

Secretario no consejero
Nombramiento: 31/08/2015

GIMENEZ- ARRIBAS GORDILLO LUIS

Secretario no consejero
Cese: 24/08/2015

MIRETE FERRER PEDRO M

Apoderado
Cese: 01/07/2015

MIRETE FERRER PEDRO M

Consejero
Nombramiento: 01/07/2015

SANCHEZ DEL VILLAR BOCETA ENRIQUE

Consejero
Nombramiento: 01/07/2015

ERNST & YOUNG SL

Auditor
Cese: 05/06/2015

LOPEZ PINTO FERNANDEZ DE NAVARRETE VICTORIANO

Apoderado
Cese: 05/06/2015

LOPEZ PINTO FERNANDEZ DE NAVARRETE VICTORIANO

Apoderado
Cese: 05/06/2015

LOPEZ PINTO FERNANDEZ DE NAVARRETE VICTORIANO

Apoderado
Cese: 20/05/2015

LOPEZ PINTO FERNANDEZ DE NAVARRETE VICTORIANO

Consejero
Cese: 20/05/2015

LOPEZ PINTO FERNANDEZ DE NAVARRETE VICTORIANO

Vicepresidente
Nombramiento: 20/05/2015

GIL GAGO JOSE ANTONIO

Consejero
Cese: 27/03/2015

PENDAS AGUIRRE ANGEL FRANCISCO

Secretario no consejero
Cese: 27/03/2015

PENDAS AGUIRRE ANGEL

Apoderado
Nombramiento: 27/03/2015

TOUBES TORRES PALOMA GUADALUPE

Secretario no consejero
Cese: 06/03/2015

FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO

Apoderado
Cese: 06/03/2015

FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO

Apoderado
Cese: 06/03/2015

FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO

Apoderado
Nombramiento: 06/03/2015

RIVILLA CALLE BLANCA

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 23/02/2015

FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO

Consejero
Cese: 23/02/2015

FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO

Presidente
Cese: 23/02/2015

RIVILLA CALLE BLANCA

Secretario
Cese: 23/02/2015

PENDAS AGUIRRE ANGEL FRANCISCO

Vicesecretario no consejero
Nombramiento: 23/02/2015

RIVILLA CALLE BLANCA

Consejero
Nombramiento: 23/02/2015

RIVILLA CALLE BLANCA

Presidente
Nombramiento: 23/02/2015

PENDAS AGUIRRE ANGEL FRANCISCO

Secretario no consejero

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por AHORRO CORPORACION DESARROLLO SGECR SA

10/11/2015 Detalles del anuncio (451902) Datos registrales: T 21463 , F 47, S 8, H M 226678, I/A 79 ( 2.11.15).

  • Cambio de denominación social

    GALA CAPITAL DESARROLLO SGEIC SA.

21/10/2015 Detalles del anuncio (421960) Datos registrales: T 21463 , F 47, S 8, H M 226678, I/A 78 (13.10.15).

  • Declaración de unipersonalidad. Socio Único.

    GALA CAPITAL PARTNERS SL.

21/10/2015 Detalles del anuncio (421959) Datos registrales: T 21463 , F 46, S 8, H M 226678, I/A 77 (13.10.15).

  • Ceses/Dimisiones

    SecreNoConsj: GIMENEZ-ARRIBAS GORDILLO LUIS. Consejero: RIVILLA CALLE BLANCA. Presidente: RIVILLA CALLE BLANCA. Consejero: GIL GAGO JOSE ANTONIO;SANCHEZ DEL VILLAR BOCETA ENRIQUE.

  • Nombramientos

    Consejero: GONZALEZ DE LUNA IÑIGO. Presidente: GONZALEZ DE LUNA IÑIGO. Consejero: SANCHEZ DEL RIO Y PRECIOSO MARIA ABIGAIL. Secretario: SANCHEZ DEL RIO Y PRECIOSO MARIA ABIGAIL. Consejero: CHICHARRO ORTEGA LUIS. Con.Delegado: GONZALEZ DE LUNA IÑIGO.

31/08/2015 Detalles del anuncio (355994) Datos registrales: T 21463 , F 46, S 8, H M 226678, I/A 76 (21.08.15).

  • Ceses/Dimisiones

    SecreNoConsj: TOUBES TORRES PALOMA GUADALUPE.

  • Nombramientos

    SecreNoConsj: GIMENEZ- ARRIBAS GORDILLO LUIS.

24/08/2015 Detalles del anuncio (349069) Datos registrales: T 21463 , F 45, S 8, H M 226678, I/A 75 (17.08.15).

  • Revocaciones

    Apoderado: MIRETE FERRER PEDRO M.

31/07/2015 Detalles del anuncio (319187) Datos registrales: T 21463 , F 45, S 8, H M 226678, I/A 74 (22.07.15).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 476.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 125.000,00 Euros.

01/07/2015 Detalles del anuncio (269943) Datos registrales: T 21463 , F 45, S 8, H M 226678, I/A 73 (23.06.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: MIRETE FERRER PEDRO M.

  • Nombramientos

    Consejero: SANCHEZ DEL VILLAR BOCETA ENRIQUE.

01/07/2015 Detalles del anuncio (269942) Datos registrales: T 21463 , F 45, S 8, H M 226678, I/A 72 (23.06.15).

  • Reelecciones

    Auditor: ERNST & YOUNG SL.

05/06/2015 Detalles del anuncio (227637) Datos registrales: T 21463 , F 44, S 8, H M 226678, I/A 71 (27.05.15).

  • Revocaciones

    Apoderado: LOPEZ PINTO FERNANDEZ DE NAVARRETE VICTORIANO;LOPEZ PINTO FERNANDEZ DE NAVARRETE VICTORIANO;LOPEZ PINTO FERNANDEZ DE NAVARRETE VICTORIANO.

20/05/2015 Detalles del anuncio (202510) Datos registrales: T 21463 , F 44, S 8, H M 226678, I/A 70 (11.05.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: LOPEZ PINTO FERNANDEZ DE NAVARRETE VICTORIANO. Vicepresid.: LOPEZ PINTO FERNANDEZ DE NAVARRETE VICTORIANO.

  • Nombramientos

    Consejero: GIL GAGO JOSE ANTONIO.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 37

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2015-214-28 10/11/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-201-28 21/10/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-201-28 21/10/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-165-28 31/08/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-160-28 24/08/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-144-28 31/07/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-122-28 01/07/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-122-28 01/07/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-104-28 05/06/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-93-28 20/05/2015 Madrid Descargar