AGITABILIS SL

Cierre provisional

POLIG INDUSTRIAL PISA, CALLE JUVENTUD 13, 41927 (MAIRENA DEL ALJARAFE).
 Mairena del Aljarafe, Sevilla  (41927)
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 27/02/2013

AMADOR LOPEZ DE LACALLE BEGOÑA

Consejero
Cese: 27/02/2013

GARCIA MORENO JUAN MANUEL

Consejero
Cese: 27/02/2013

GARCIA MORENO JUAN MANUEL

Presidente
Cese: 27/02/2013

GARCIA MORENO JUAN MANUEL

Consejero delegado solidario
Nombramiento: 28/06/2011

LAGO GARCIA MANUEL

Secretario no consejero
Nombramiento: 14/06/2011

PEREZ HIDALGO IGNACIO

Apoderado
Cese: 30/03/2011

LOSADA CASTELL IVAN MANUEL

Consejero
Cese: 30/03/2011

SEGURA RAMON GABRIEL RAFAEL

Secretario
Cese: 30/03/2011

SEGURA RAMON GABRIEL RAFAEL

Consejero
Cese: 29/01/2010

DELGADO DURAN MIGUEL

Administrador único
Nombramiento: 29/01/2010

GARCIA MORENO JUAN MANUEL

Presidente
Nombramiento: 29/01/2010

SEGURA RAMON GABRIEL RAFAEL

Secretario
Nombramiento: 29/01/2010

GARCIA MORENO JUAN MANUEL

Consejero delegado solidario
Nombramiento: 29/01/2010

VERDEJO MARTINEZ MIGUEL ANGEL

Consejero delegado solidario
Nombramiento: 29/01/2010

VERDEJO MARTINEZ MIGUEL ANGEL

Consejero
Nombramiento: 29/01/2010

SEGURA RAMON GABRIEL RAFAEL

Consejero
Nombramiento: 29/01/2010

LOSADA CASTELL IVAN MANUEL

Consejero
Nombramiento: 29/01/2010

GARCIA MORENO JUAN MANUEL

Consejero
Nombramiento: 29/01/2010

AMADOR LOPEZ DE LACALLE BEGOÑA

Consejero
Cese: 20/07/2009

CERDA SANJUAN RAMON

Administrador solidario
Cese: 20/07/2009

BELDA ALEIXANDRE JESUS

Administrador solidario
Nombramiento: 20/07/2009

DELGADO DURAN MIGUEL

Administrador único
Nombramiento: 03/02/2009

CERDA SANJUAN RAMON

Administrador solidario
Nombramiento: 03/02/2009

BELDA ALEIXANDRE JESUS

Administrador solidario

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por AGITABILIS SL

24/08/2016 Detalles del anuncio (350697) Datos registrales: T 5368 , F 163, S 8, H SE 81463, I/A 8 1 ( 8.06.16).

  • Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas

27/02/2013 Detalles del anuncio (99699) Datos registrales: T 5368 , F 163, S 8, H SE 81463, I/A 8 (14.02.13).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: AMADOR LOPEZ DE LACALLE BEGOÑA;GARCIA MORENO JUAN MANUEL. Presidente: GARCIA MORENO JUAN MANUEL. Cons.Del.Sol: GARCIA MORENO JUAN MANUEL.

28/06/2011 Detalles del anuncio (273304) Datos registrales: T 5368 , F 163, S 8, H SE 81463, I/A 7 (10.06.11).

  • Nombramientos

    SecreNoConsj: LAGO GARCIA MANUEL.

21/06/2011 Detalles del anuncio (178522)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Mayo de 2011) Año: 2009

14/06/2011 Detalles del anuncio (255130) Datos registrales: T 5023 , F 99, S 8, H SE 81463, I/A 6 ( 2.06.11).

  • Nombramientos

    Apoderado: PEREZ HIDALGO IGNACIO.

01/06/2011 Detalles del anuncio (163119)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Mayo de 2011) Año: 2008

30/03/2011 Detalles del anuncio (142853) Datos registrales: T 5023 , F 99, S 8, H SE 81463, I/A 5 (17.03.11).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: LOSADA CASTELL IVAN MANUEL. Secretario: SEGURA RAMON GABRIEL RAFAEL. Consejero: SEGURA RAMON GABRIEL RAFAEL.

29/01/2010 Detalles del anuncio (39263) Datos registrales: T 5023 , F 98, S 8, H SE 81463, I/A 4 (20.01.10).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: DELGADO DURAN MIGUEL.

  • Nombramientos

    Presidente: GARCIA MORENO JUAN MANUEL. Secretario: SEGURA RAMON GABRIEL RAFAEL. Cons.Del.Sol: GARCIA MORENO JUAN MANUEL;VERDEJO MARTINEZ MIGUEL ANGEL. Consejero: VERDEJO MARTINEZ MIGUEL ANGEL;SEGURA RAMON GABRIEL RAFAEL;LOSADA CASTELL IVAN MANUEL;GARCIA MORENO JUAN MANUEL;AMADOR LOPEZ DE LACALLE BEGOÑA.

  • Modificaciones Estatutarias

    Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración.

11/08/2009 Detalles del anuncio (353255) Datos registrales: T 5023 , F 93, S 8, H SE 81463, I/A 3 (24.07.09).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 4.169.172,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.172.178,00 Euros.

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: 4. Capital.-.

20/07/2009 Detalles del anuncio (322501) Datos registrales: T 5023 , F 92, S 8, H SE 81463, I/A 2 ( 8.07.09).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Solid.: CERDA SANJUAN RAMON;BELDA ALEIXANDRE JESUS.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: DELGADO DURAN MIGUEL.

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-.Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único.

  • Cambio de domicilio social

    POLIG INDUSTRIAL PISA, CALLE JUVENTUD 13, 41927 (MAIRENA DEL ALJARAFE).

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 11

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2016-161-41 24/08/2016 Sevilla Descargar
BORME-A-2013-40-41 27/02/2013 Sevilla Descargar
BORME-A-2011-122-41 28/06/2011 Sevilla Descargar
BORME-B-2011-118-41 21/06/2011 Sevilla Descargar
BORME-A-2011-113-41 14/06/2011 Sevilla Descargar
BORME-B-2011-104-41 01/06/2011 Sevilla Descargar
BORME-A-2011-62-41 30/03/2011 Sevilla Descargar
BORME-A-2010-19-41 29/01/2010 Sevilla Descargar
BORME-A-2009-151-41 11/08/2009 Sevilla Descargar
BORME-A-2009-135-41 20/07/2009 Sevilla Descargar