ACYCO ACEITUNAS Y CONSERVAS SA

Activa

CARRETERA NACIONAL IV (KM 556.500)
 Dos Hermanas, Sevilla  (41700)
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 01/12/2014

DELOITTE & TOUCHE ESPAÑA SL

Auditor
Cese: 17/06/2014

MORENO MORENO JOSE

Consejero
Cese: 17/06/2014

DE MORA PEREZ FRANCISCO

Consejero
Cese: 17/06/2014

LUQUE LUQUE ANTONIO

Consejero
Cese: 17/06/2014

MORENO MORENO JOSE

Presidente
Cese: 17/06/2014

DE MORA PEREZ FRANCISCO

Secretario
Nombramiento: 17/06/2014

DE MORA PEREZ FRANCISCO

Administrador único
Nombramiento: 22/05/2013

ERNST &YOUNG SL

Auditor
Cese: 05/12/2011

HOJIBLANCA SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA

Consejero
Cese: 05/12/2011

JORDA CASTRO MARIA LUISA

Consejero
Cese: 05/12/2011

CARBO FERNANDEZ JAIME

Consejero
Cese: 05/12/2011

CARBO FERNANDEZ JAIME

Consejero delegado
Cese: 05/12/2011

HERNANDEZ FLORES DAVID

Presidente
Cese: 05/12/2011

HERNANDEZ FLORES DAVID

Consejero
Cese: 05/12/2011

LANDAZURI PALACIOS JUAN-JOSE

Consejero
Cese: 05/12/2011

MARQUEZ LEITON MARIA LUISA

Secretario no consejero
Nombramiento: 05/12/2011

MORENO MORENO JOSE

Consejero
Nombramiento: 05/12/2011

DE MORA PEREZ FRANCISCO

Consejero
Nombramiento: 05/12/2011

LUQUE LUQUE ANTONIO

Consejero
Nombramiento: 05/12/2011

MORENO MORENO JOSE

Presidente
Nombramiento: 05/12/2011

DE MORA PEREZ FRANCISCO

Secretario
Cese: 29/09/2011

LIMONES ALCOCER ENRIQUE

Consejero
Nombramiento: 29/09/2011

HOJIBLANCA SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA

Consejero
Nombramiento: 30/08/2011

MORENO MORENO JOSE

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 30/08/2011

DE MORA PEREZ FRANCISCO

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 30/08/2011

LUQUE LUQUE ANTONIO

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 29/07/2011

POTO MONGE ENCARNACION

Consejero
Cese: 29/07/2011

POTO MONGE ENCARNACION

Presidente
Cese: 29/07/2011

SOS GIRBES VICENTE

Consejero
Cese: 29/07/2011

LANDAZURI PALACIOS JUAN-JOSE

Secretario
Nombramiento: 29/07/2011

CARBO FERNANDEZ JAIME

Consejero
Nombramiento: 29/07/2011

HERNANDEZ FLORES DAVID

Consejero
Nombramiento: 29/07/2011

HERNANDEZ FLORES DAVID

Presidente
Nombramiento: 29/07/2011

JORDA CASTRO MARIA LUISA

Consejero
Nombramiento: 29/07/2011

CARBO FERNANDEZ JAIME

Consejero delegado
Nombramiento: 29/07/2011

MARQUEZ LEITON MARIA LUISA

Secretario no consejero
Cese: 19/07/2011

MURIEL JIMENEZ JOSE MANUEL

Consejero
Cese: 19/07/2011

MURIEL JIMENEZ JOSE MANUEL

Consejero delegado
Cese: 19/07/2011

MURIEL JIMENEZ JOSE MANUEL

Secretario
Nombramiento: 19/07/2011

LANDAZURI PALACIOS JUAN-JOSE

Secretario
Cese: 01/12/2010

REDONDO SANCHEZ DE RON CARLOS

Consejero
Nombramiento: 01/12/2010

LANDAZURI PALACIOS JUAN-JOSE

Consejero
Nombramiento: 01/12/2010

SOS GIRBES VICENTE

Consejero
Cese: 01/12/2010

QUEROL SANCHO JOSE

Consejero
Cese: 01/12/2010

QUEROL SANCHO JOSE

Secretario
Nombramiento: 01/12/2010

MURIEL JIMENEZ JOSE MANUEL

Secretario
Nombramiento: 01/12/2010

LANDAZURI PALACIOS JUAN-JOSE

Consejero

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por ACYCO ACEITUNAS Y CONSERVAS SA

12/09/2016 Detalles del anuncio (372851) Datos registrales: T 5079 , F 104, S 8, H SE 20814, I/A 77 1 (25.08.16).

  • Otros Conceptos

    Conforme al Articulo 231 del Reglamento del Registro Mercantil, NO EXISTEN OBSTACULOS PARA LA FUSION de la Sociedad ACYCO ACEITUNAS Y CONSERVAS, S.A., que será ABSORBIDA por la Sociedad cooperativa denominada DCOOP, S. COOP. AND., con domicilio en Antequera -Málaga-, quedando aquella EXTINGUIDA.

05/03/2015 Detalles del anuncio (97012) Datos registrales: T 5079 , F 104, S 8, H SE 20814, I/A 77 (24.02.15).

  • Modificaciones Estatutarias

    30. Retribución cargo..

01/12/2014 Detalles del anuncio (490020) Datos registrales: T 2219 , F 152, S 8, H SE 20814, I/A 20 (19.12.03).

  • Reelecciones

    Auditor: DELOITTE & TOUCHE ESPAÑA SL.

17/06/2014 Detalles del anuncio (253657) Datos registrales: T 5079 , F 101, S 8, H SE 20814, I/A 76 ( 6.06.14).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: MORENO MORENO JOSE;DE MORA PEREZ FRANCISCO;LUQUE LUQUE ANTONIO. Presidente: MORENO MORENO JOSE. Secretario: DE MORA PEREZ FRANCISCO.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: DE MORA PEREZ FRANCISCO.

  • Modificaciones Estatutarias

    Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Modifica y refunde los Estatutos Sociales, artículos 1 al 40.-.

22/05/2013 Detalles del anuncio (237314) Datos registrales: T 5079 , F 100, S 8, H SE 20814, I/A 75 (10.05.13).

  • Nombramientos

    Auditor: ERNST &YOUNG SL.

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 30.189.507,00 Euros. Resultante Suscrito: 9.168.180,00 Euros.

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 8º DE LOSESTATUTOS SOCIALES.- .MODIFICADO EL ARTICULO 15º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- .

05/12/2011 Detalles del anuncio (485553) Datos registrales: T 5079 , F 99, S 8, H SE 20814, I/A 74 (21.11.11).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: HOJIBLANCA SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA;JORDA CASTRO MARIA LUISA;CARBO FERNANDEZ JAIME. Con.Delegado: CARBO FERNANDEZ JAIME. Presidente: HERNANDEZ FLORES DAVID. Consejero: HERNANDEZ FLORES DAVID;LANDAZURI PALACIOS JUAN-JOSE. SecreNoConsj: MARQUEZ LEITON MARIA LUISA.

  • Nombramientos

    Consejero: MORENO MORENO JOSE;DE MORA PEREZ FRANCISCO;LUQUE LUQUE ANTONIO. Presidente: MORENO MORENO JOSE. Secretario: DE MORA PEREZ FRANCISCO.

  • Modificaciones Estatutarias

    15. Funcionamiento Junta Gral.-. 32. Administración y Representacion.-.

29/09/2011 Detalles del anuncio (390056) Datos registrales: T 5065 , F 84, S 8, H SE 20814, I/A 73 (16.09.11).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: LIMONES ALCOCER ENRIQUE.

  • Nombramientos

    Consejero: HOJIBLANCA SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA.

01/09/2011 Detalles del anuncio (409248)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Agosto de 2011) Año: 2010

30/08/2011 Detalles del anuncio (356157) Datos registrales: T 5065 , F 84, S 8, H SE 20814, I/A 72 (19.08.11).

  • Nombramientos

    Apo.Man.Soli: MORENO MORENO JOSE;DE MORA PEREZ FRANCISCO;LUQUE LUQUE ANTONIO.

03/08/2011 Detalles del anuncio (243945)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Julio de 2011) Año: 2009

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 28

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2016-174-41 12/09/2016 Sevilla Descargar
BORME-A-2015-44-41 05/03/2015 Sevilla Descargar
BORME-A-2014-229-41 01/12/2014 Sevilla Descargar
BORME-A-2014-113-41 17/06/2014 Sevilla Descargar
BORME-A-2013-94-41 22/05/2013 Sevilla Descargar
BORME-A-2011-230-41 05/12/2011 Sevilla Descargar
BORME-A-2011-186-41 29/09/2011 Sevilla Descargar
BORME-B-2011-167-41 01/09/2011 Sevilla Descargar
BORME-A-2011-165-41 30/08/2011 Sevilla Descargar
BORME-B-2011-147-41 03/08/2011 Sevilla Descargar