ESPAIS CATALUNYA MEDITERRANEO SA

Activa

CL MALLORCA Num.269 (BARCELONA).
Barcelona
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 18/12/2024

F & M AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS SLP

Auditor de cuentas
Nombramiento: 09/05/2022

F & M AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS SLP

Auditor de cuentas
Cese: 04/12/2020

AUSEJO SEGURA JOSE JOAQUIN

Consejero
Cese: 04/12/2020

AUSEJO SEGURA JOSE JOAQUIN

Presidente
Cese: 04/12/2020

AÑON GASCON HECTOR

Consejero
Cese: 04/12/2020

AUSEJO ASIAIN JOAQUIN

Consejero
Cese: 04/12/2020

VALLES FONTANALS XAVIER

Secretario no consejero
Cese: 04/12/2020

AUSEJO SEGURA JOSE JOAQUIN

Consejero delegado
Nombramiento: 04/12/2020

AUSEJO SEGURA JOSE JOAQUIN

Administrador único
Cese: 13/06/2016

PINEDA BALAGUER ANNA

Apoderado
Cese: 29/09/2015

MATAS BONET RAFAEL

Vicesecretario no consejero
Nombramiento: 29/09/2015

AUSEJO SEGURA JOSE JOAQUIN

Consejero delegado
Cese: 26/02/2015

SANCHEZ ENCINAS LUIS JOSE

Secretario no consejero
Cese: 26/02/2015

INVERCARTERA CAPITAL SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO S

Consejero
Cese: 26/02/2015

CATALUNYACAIXA CAPITAL SA

Consejero
Cese: 26/02/2015

TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SL

Consejero
Cese: 26/02/2015

FONOMED GESTION TELEFONICA MEDITERRANEO SA

Consejero
Cese: 26/02/2015

SANABRA GAFAROT JORDI

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 26/02/2015

FONOMED GESTION TELEFONICA MEDITERRANEO SA

Presidente
Cese: 26/02/2015

INVERCARTERA CAPITAL SCR SA

Consejero delegado mancomunado
Cese: 26/02/2015

CATALUNYACAIXA CAPITAL SA

Consejero delegado mancomunado
Cese: 26/02/2015

FONOMED GESTION TELEFONICA MEDITERRANEO SA

Consejero delegado mancomunado
Cese: 26/02/2015

TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SL

Consejero delegado mancomunado
Cese: 26/02/2015

RODRIGUEZ CAÑAS MARCOS

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 26/02/2015

DUDE ALVAREZ ESTEFANIA

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 26/02/2015

FINA CASANOVA JOSEP JAUME

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 26/02/2015

AUSEJO SEGURA JOSE JOAQUIN

Consejero
Nombramiento: 26/02/2015

AUSEJO SEGURA JOSE JOAQUIN

Presidente
Nombramiento: 26/02/2015

AÑON GASCON HECTOR

Consejero
Nombramiento: 26/02/2015

AUSEJO ASIAIN JOAQUIN

Consejero
Nombramiento: 26/02/2015

VALLES FONTANALS XAVIER

Secretario no consejero
Cese: 05/08/2014

PERICH PARCERISAS JOSEP

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 05/08/2014

FINA CASANOVA JOSEP JAUME

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 04/03/2014

TORRELLAS JOVANI MATIAS

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 04/03/2014

PERICH PARCERISAS JOSEP

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 29/11/2012

GUERRA VIÑA ESTHER

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 29/11/2012

RODRIGUEZ CAÑAS MARCOS

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 29/11/2012

FABREGAT CLOTET JOSEP

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 29/11/2012

DUDE ALVAREZ ESTEFANIA

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por ESPAIS CATALUNYA MEDITERRANEO SA

18/12/2024 Detalles del anuncio (548085) Datos registrales: S 8 , H B 309992, I/A 37 (11.12.24).

  • Nombramientos

    AUDIT.CUENT.: F & M AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS SLP.

09/05/2022 Detalles del anuncio (204101) Datos registrales: T 42236 , F 159, S 8, H B 309992, I/A 36 (28.04.22).

  • Nombramientos

    AUDIT.CUENT.: F & M AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS SLP.

04/12/2020 Detalles del anuncio (428218) Datos registrales: T 42236 , F 159, S 8, H B 309992, I/A 35 (25.11.20).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: AUSEJO SEGURA JOSE JOAQUIN. PRESIDENTE: AUSEJO SEGURA JOSE JOAQUIN. CONSEJERO: AÑON GASCON HECTOR;AUSEJO ASIAIN JOAQUIN. SECR.NO CONS: VALLES FONTANALS XAVIER. CONS. DELEG.: AUSEJO SEGURA JOSE JOAQUIN.

  • Nombramientos

    ADM.UNICO: AUSEJO SEGURA JOSE JOAQUIN.

  • Ampliación de Capital

    Suscrito: 24.712,02 Euros. Desembolsado: 24.712,02 Euros. Resultante Suscrito: 1.617.785,46 Euros. Resultante Desembolsado: 1.617.785,46 Euros.

13/06/2016 Detalles del anuncio (248320) Datos registrales: T 42236 , F 159, S 8, H B 309992, I/A 34 ( 3.06.16).

  • Revocaciones

    APODERADO: PINEDA BALAGUER ANNA.

05/11/2015 Detalles del anuncio (446245) Datos registrales: T 42236 , F 158, S 8, H B 309992, I/A 33 (29.10.15).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 24.958.150,56 Euros. Resultante Suscrito: 1.593.073,44 Euros.

29/09/2015 Detalles del anuncio (391524) Datos registrales: T 42236 , F 158, S 8, H B 309992, I/A 32 (22.09.15).

  • Revocaciones

    V-SEC NO CON: MATAS BONET RAFAEL.

  • Nombramientos

    CONS. DELEG.: AUSEJO SEGURA JOSE JOAQUIN.

26/02/2015 Detalles del anuncio (84448) Datos registrales: T 42236 , F 154, S 8, H B 309992, I/A 30 (19.02.15).

  • Revocaciones

    SECR.NO CONS: SANCHEZ ENCINAS LUIS JOSE. CONSEJERO: INVERCARTERA CAPITAL SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO S;CATALUNYACAIXA CAPITAL SA;TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SL;FONOMED GESTION TELEFONICA MEDITERRANEO SA. REPR.143 RRM: SANABRA GAFAROT JORDI. PRESIDENTE: FONOMED GESTION TELEFONICA MEDITERRANEO SA. CONS.DEL.MAN: INVERCARTERA CAPITAL SCR SA;CATALUNYACAIXA CAPITAL SA;FONOMED GESTION TELEFONICA MEDITERRANEO SA;TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SL. REPR.143 RRM: RODRIGUEZ CAÑAS MARCOS;DUDE ALVAREZ ESTEFANIA;FINA CASANOVA JOSEP JAUME.

  • Nombramientos

    CONSEJERO: AUSEJO SEGURA JOSE JOAQUIN. PRESIDENTE: AUSEJO SEGURA JOSE JOAQUIN. CONSEJERO: AÑON GASCON HECTOR;AUSEJO ASIAIN JOAQUIN. SECR.NO CONS: VALLES FONTANALS XAVIER.

26/02/2015 Detalles del anuncio (84449) Datos registrales: T 42236 , F 155, S 8, H B 309992, I/A 31 (19.02.15).

  • Modificaciones Estatutarias

    MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SUPRESION DE CLASES DE ACCIONES.RENUMERACION DE ACCIONES.

05/08/2014 Detalles del anuncio (321064) Datos registrales: T 42236 , F 154, S 8, H B 309992, I/A 29 (28.07.14).

  • Revocaciones

    REPR.143 RRM: PERICH PARCERISAS JOSEP.

  • Nombramientos

    REPR.143 RRM: FINA CASANOVA JOSEP JAUME.

04/03/2014 Detalles del anuncio (98639) Datos registrales: T 42236 , F 154, S 8, H B 309992, I/A 28 (25.02.14).

  • Revocaciones

    REPR.143 RRM: TORRELLAS JOVANI MATIAS.

  • Nombramientos

    REPR.143 RRM: PERICH PARCERISAS JOSEP.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 29

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2024-243-08 18/12/2024 Barcelona Descargar
BORME-A-2022-87-08 09/05/2022 Barcelona Descargar
BORME-A-2020-234-08 04/12/2020 Barcelona Descargar
BORME-A-2016-111-08 13/06/2016 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-212-08 05/11/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-186-08 29/09/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-39-08 26/02/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-39-08 26/02/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-147-08 05/08/2014 Barcelona Descargar
BORME-A-2014-43-08 04/03/2014 Barcelona Descargar