P N JOVELLANOS 5 SL

Extinta

CL PARIS Num.64 ESC.B P.1 PTA.4 (BARCELONA).
Barcelona
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 03/07/2013

RUIZ DE MARCOS PEDRO

Administrador único
Nombramiento: 03/07/2013

COMPAS CONCURSAL SLP

Administrador concurs.
Nombramiento: 03/07/2013

JORI TOLOSA JOSE LUIS

Representante administrador concurs.
Cese: 07/12/2011

GARRIDO CRISTO JOSE MIGUEL

Administrador único
Nombramiento: 07/12/2011

RUIZ DE MARCOS PEDRO

Administrador único
Cese: 25/11/2011

MICHEL ITALO LAVIN DONOSO

Apoderado
Nombramiento: 25/11/2011

PAEZ MORILLAS JOSE RAMON

Apoderado
Nombramiento: 25/11/2011

MASO PEQUEÑO RAFAEL

Apoderado
Nombramiento: 25/11/2011

MARCELO MARTIN BILOTTA

Apoderado
Cese: 11/08/2011

MARTIN ESTIRAGUES BERNARDO LEOCADIO

Apoderado
Cese: 11/08/2011

REQUELME MARECA MARIA DOLORES

Apoderado
Cese: 11/08/2011

LASCA OPRIS CRISTIAN EUGEN

Apoderado
Cese: 11/08/2011

LOPEZ MORA GUSTAVO ADOLFO

Apoderado
Cese: 11/08/2011

EVA BRENDEMUHL

Apoderado
Cese: 11/08/2011

SANCHEZ SOLER JESUS

Apoderado
Cese: 11/08/2011

MARTINEZ ROIG FRANCESC XAVIER

Apoderado
Nombramiento: 11/08/2011

VILLAVERDE CARNEVALLI RAMON

Apoderado
Nombramiento: 11/08/2011

MICHEL ITALO LAVIN DONOSO

Apoderado
Nombramiento: 11/08/2011

SERRA SEDEÑO FRANCISCO JOSE

Apoderado
Nombramiento: 11/08/2011

RUIZ DE MARCOS PEDRO

Apoderado
Cese: 10/08/2011

ALASDAIR DEREK MURDOCH

Administrador único
Nombramiento: 10/08/2011

GARRIDO CRISTO JOSE MIGUEL

Administrador único
Cese: 16/02/2010

ERIC ANDRE

Administrador único
Nombramiento: 16/02/2010

ALASDAIR DEREK MURDOCH

Administrador único
Cese: 30/06/2009

EVA BRENDEMUHL GUBERT

Apoderado
Nombramiento: 30/06/2009

EVA BRENDEMUHL

Apoderado
Nombramiento: 30/06/2009

SANCHEZ SOLER JESUS

Apoderado
Nombramiento: 30/06/2009

MARTINEZ ROIG FRANCESC XAVIER

Apoderado

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by P N JOVELLANOS 5 SL

18/05/2015 Details of the advert (198093) Registry data: T 43162 , F 14, S 8, H B 329282, I/A 23 ( 8.05.15).

  • Otros Conceptos

    JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 142/2013, AUTO FIRME DE FECHA 27/03/2015, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD.

  • Extinción

04/11/2013 Details of the advert (467127) Registry data: T 43162 , F 13, S 8, H B 329282, I/A 22 (24.10.13).

  • Otros Conceptos

    JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 142/2013, AUTO FIRME DE FECHA 13/05/2013, POR LA QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.

03/07/2013 Details of the advert (302307) Registry data: T 38626 , F 138, S 8, H B 329282, I/A 21 (21.06.13).

  • Revocaciones

    ADM.UNICO: RUIZ DE MARCOS PEDRO.

  • Nombramientos

    ADM.CONCURS.: COMPAS CONCURSAL SLP. REP.ADM.CONC: JORI TOLOSA JOSE LUIS.

  • Otros Conceptos

    JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE CONCURSO VOLUNTARIO 142/2013, AUTOS FIRMES DE FECHAS 14/03/2013: DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y 12/04/2013: APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION.

  • Disolución

    Judicial.

26/04/2013 Details of the advert (196242) Registry data: T 38626 , F 138, S 8, H B 329282, I/A 20 (17.04.13).

  • Cambio de domicilio social

    CL PARIS Num.64 ESC.B P.1 PTA.4 (BARCELONA).

07/12/2011 Details of the advert (486645) Registry data: T 38626 , F 138, S 8, H B 329282, I/A 19 (23.11.11).

  • Revocaciones

    ADM.UNICO: GARRIDO CRISTO JOSE MIGUEL.

  • Nombramientos

    ADM.UNICO: RUIZ DE MARCOS PEDRO.

25/11/2011 Details of the advert (471322) Registry data: T 38626 , F 136, S 8, H B 329282, I/A 18 (14.11.11).

  • Revocaciones

    APODERADO: MICHEL ITALO LAVIN DONOSO.

  • Nombramientos

    APODERADO: PAEZ MORILLAS JOSE RAMON;MASO PEQUEÑO RAFAEL;MARCELO MARTIN BILOTTA.

21/09/2011 Details of the advert (559979)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Agosto de 2011) Año: 2009

21/09/2011 Details of the advert (569305)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Agosto de 2011) Año: 2010

11/08/2011 Details of the advert (334498) Registry data: T 38626 , F 134, S 8, H B 329282, I/A 16 ( 1.08.11).

  • Revocaciones

    APODERADO: MARTIN ESTIRAGUES BERNARDO LEOCADIO;REQUELME MARECA MARIA DOLORES;LASCA OPRIS CRISTIAN EUGEN;LOPEZ MORA GUSTAVO ADOLFO;EVA BRENDEMUHL;SANCHEZ SOLER JESUS;MARTINEZ ROIG FRANCESC XAVIER.

  • Nombramientos

    APODERADO: VILLAVERDE CARNEVALLI RAMON;MICHEL ITALO LAVIN DONOSO.

11/08/2011 Details of the advert (334590) Registry data: T 38626 , F 135, S 8, H B 329282, I/A 17 ( 1.08.11).

  • Nombramientos

    APODERADO: SERRA SEDEÑO FRANCISCO JOSE;RUIZ DE MARCOS PEDRO.

Mercantile Registry documents related: 15

#CVE
Date
State
BORME-A-2015-91-08 18/05/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2013-210-08 04/11/2013 Barcelona Descargar
BORME-A-2013-124-08 03/07/2013 Barcelona Descargar
BORME-A-2013-79-08 26/04/2013 Barcelona Descargar
BORME-A-2011-231-08 07/12/2011 Barcelona Descargar
BORME-A-2011-224-08 25/11/2011 Barcelona Descargar
BORME-B-2011-180-08 21/09/2011 Barcelona Descargar
BORME-B-2011-180-08 21/09/2011 Barcelona Descargar
BORME-A-2011-153-08 11/08/2011 Barcelona Descargar
BORME-A-2011-153-08 11/08/2011 Barcelona Descargar