ONEXPRESS SL

Extinta

CL 29, PARC LOGISTIC DE LA ZONA FRANCA, NUM.10 (BARCELONA).
Barcelona
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Nombramiento: 17/06/2010

ALONSO MARTINEZ JAVIER

Apoderado
Cese: 28/05/2010

PERALTA LECHUGA FERNANDO

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 28/05/2010

GARCIA CAÑADAS FRANCISCO

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 11/02/2010

NEIRA RODRIGUEZ MARCOS

Apoderado
Cese: 22/05/2009

TORREBLANCA RAMIREZ MANUEL

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 22/05/2009

PERALTA LECHUGA FERNANDO

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 11/03/2009

PEÑA GOMEZ DIEGO

Apoderado
Cese: 04/03/2009

ERROZ BELTRAN JUAN BAUTISTA

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 04/03/2009

TORREBLANCA RAMIREZ MANUEL

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by ONEXPRESS SL

18/02/2011 Details of the advert (81361)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Enero de 2011) Año: 2009

20/08/2010 Details of the advert (325510) Registry data: T 41667 , F 192, S 8, H B 108230, I/A 14 ( 9.08.10).

  • Extinción

17/06/2010 Details of the advert (241503) Registry data: T 41667 , F 191, S 8, H B 108230, I/A 13 ( 7.06.10).

  • Nombramientos

    APODERADO: ALONSO MARTINEZ JAVIER.

28/05/2010 Details of the advert (213393) Registry data: T 41667 , F 191, S 8, H B 108230, I/A 12 (18.05.10).

  • Revocaciones

    REPR.143 RRM: PERALTA LECHUGA FERNANDO.

  • Nombramientos

    REPR.143 RRM: GARCIA CAÑADAS FRANCISCO.

18/03/2010 Details of the advert (135143)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Febrero de 2010) Año: 2008

11/02/2010 Details of the advert (58468) Registry data: T 26773 , F 42, S 8, H B 108230, I/A 11 (29.01.10).

  • Nombramientos

    APODERADO: NEIRA RODRIGUEZ MARCOS.

01/02/2010 Details of the advert (40050) Registry data: T 26773 , F 42, S 8, H B 108230, I/A 10 (19.01.10).

  • Cambio de domicilio social

    CL 29, PARC LOGISTIC DE LA ZONA FRANCA, NUM.10 (BARCELONA).

22/05/2009 Details of the advert (232932) Registry data: T 26773 , F 42, S 8, H B 108230, I/A 9 (11.05.09).

  • Revocaciones

    REPR.143 RRM: TORREBLANCA RAMIREZ MANUEL.

  • Nombramientos

    REPR.143 RRM: PERALTA LECHUGA FERNANDO.

11/03/2009 Details of the advert (123902) Registry data: T 26773 , F 41, S 8, H B 108230, I/A 8 (27.02.09).

  • Nombramientos

    APODERADO: PEÑA GOMEZ DIEGO.

04/03/2009 Details of the advert (111406) Registry data: T 26773 , F 41, S 8, H B 108230, I/A 7 (20.02.09).

  • Revocaciones

    REPR.143 RRM: ERROZ BELTRAN JUAN BAUTISTA.

  • Nombramientos

    REPR.143 RRM: TORREBLANCA RAMIREZ MANUEL.

Mercantile Registry documents related: 10

#CVE
Date
State
BORME-B-2011-34-08 18/02/2011 Barcelona Descargar
BORME-A-2010-160-08 20/08/2010 Barcelona Descargar
BORME-A-2010-114-08 17/06/2010 Barcelona Descargar
BORME-A-2010-101-08 28/05/2010 Barcelona Descargar
BORME-B-2010-53-08 18/03/2010 Barcelona Descargar
BORME-A-2010-28-08 11/02/2010 Barcelona Descargar
BORME-A-2010-20-08 01/02/2010 Barcelona Descargar
BORME-A-2009-95-08 22/05/2009 Barcelona Descargar
BORME-A-2009-48-08 11/03/2009 Barcelona Descargar
BORME-A-2009-43-08 04/03/2009 Barcelona Descargar