INVERZAMORA JM SL

Extinta

Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Cese: 05/02/2016

SOTOMAYOR RAMIREZ MANUEL

Liquidador mancomunado
Cese: 05/02/2016

FERNANDEZ GARCIA JOSE

Liquidador mancomunado
Cese: 05/02/2016

FERNANDEZ GARCIA JOSE

Consejero
Cese: 05/02/2016

FERNANDEZ GARCIA JOSE

Presidente
Cese: 05/02/2016

SOTOMAYOR RAMIREZ MANUEL

Consejero
Cese: 05/02/2016

SOTOMAYOR RAMIREZ MANUEL

Secretario
Cese: 05/02/2016

CRESPO RIESCO JAVIER

Consejero
Cese: 05/02/2016

PRIETO HERRERO JOSE MANUEL

Consejero
Nombramiento: 05/02/2016

SOTOMAYOR RAMIREZ MANUEL

Liquidador mancomunado
Nombramiento: 05/02/2016

FERNANDEZ GARCIA JOSE

Liquidador mancomunado
Cese: 19/11/2010

FERNANDEZ MAESTRO PABLO

Administrador único
Nombramiento: 19/11/2010

FERNANDEZ GARCIA JOSE

Consejero
Nombramiento: 19/11/2010

FERNANDEZ GARCIA JOSE

Presidente
Nombramiento: 19/11/2010

SOTOMAYOR RAMIREZ MANUEL

Consejero
Nombramiento: 19/11/2010

SOTOMAYOR RAMIREZ MANUEL

Secretario
Nombramiento: 19/11/2010

CRESPO RIESCO JAVIER

Consejero
Nombramiento: 19/11/2010

PRIETO HERRERO JOSE MANUEL

Consejero
Cese: 15/06/2010

FERNANDEZ GARCIA JOSE

Consejero
Cese: 15/06/2010

FERNANDEZ GARCIA JOSE

Presidente
Cese: 15/06/2010

MATILLA PEÑA JOSE RAMON

Consejero
Cese: 15/06/2010

MATILLA PEÑA JOSE RAMON

Secretario
Cese: 15/06/2010

FERNANDEZ GARCIA JOSE

Consejero delegado
Cese: 15/06/2010

FERNANDEZ MAESTRO PABLO

Consejero
Nombramiento: 15/06/2010

FERNANDEZ MAESTRO PABLO

Administrador único

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by INVERZAMORA JM SL

05/02/2016 Details of the advert (53785) Registry data: T 235 , F 91, S 8, H ZA 1818, I/A 13 (27.01.16).

  • Ceses/Dimisiones

    Liquidador M: SOTOMAYOR RAMIREZ MANUEL;FERNANDEZ GARCIA JOSE. Consejero: FERNANDEZ GARCIA JOSE. Presidente: FERNANDEZ GARCIA JOSE. Consejero: SOTOMAYOR RAMIREZ MANUEL. Secretario: SOTOMAYOR RAMIREZ MANUEL. Consejero: CRESPO RIESCO JAVIER;PRIETO HERRERO JOSE MANUEL.

  • Nombramientos

    Liquidador M: SOTOMAYOR RAMIREZ MANUEL;FERNANDEZ GARCIA JOSE.

  • Disolución

    Voluntaria.

  • Extinción

24/05/2012 Details of the advert (221564) Registry data: T 235 , F 91, S 8, H ZA 1818, I/A 12 (15.05.12).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 3.750,00 Euros. Resultante Suscrito: 33.750,00 Euros.

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: 6. Capital.-.

09/08/2011 Details of the advert (269315)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Julio de 2011) Año: 2010

26/04/2011 Details of the advert (181863) Registry data: T 235 , F 91, S 8, H ZA 1818, I/A 11 (11.04.11).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 7.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 37.500,00 Euros.

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: 6. Capital.-.

19/11/2010 Details of the advert (428856) Registry data: T 235 , F 91, S 8, H ZA 1818, I/A 10 (10.11.10).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: FERNANDEZ MAESTRO PABLO.

  • Nombramientos

    Consejero: FERNANDEZ GARCIA JOSE. Presidente: FERNANDEZ GARCIA JOSE. Consejero: SOTOMAYOR RAMIREZ MANUEL. Secretario: SOTOMAYOR RAMIREZ MANUEL. Consejero: CRESPO RIESCO JAVIER;PRIETO HERRERO JOSE MANUEL.

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: 3. Objeto.-.Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración.

  • Ampliación del Objeto Social

    Actividad de agente exclusivo de GVC GAESCO VALORES SOCIEDAD DE VALORES SA, en los términos de la ley 24/1988 de 28 de julio del Mercado de Valores, en el Real Decreto 217/2008 de 15 de febrero sobre régimen jurídico de las empresas de Servicios de Inversión y demás disposiciones legales aplicables.

09/09/2010 Details of the advert (515234)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Agosto de 2010) Año: 2009

15/06/2010 Details of the advert (239022) Registry data: T 235 , F 90, S 8, H ZA 1818, I/A 9 ( 4.06.10).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: FERNANDEZ GARCIA JOSE. Presidente: FERNANDEZ GARCIA JOSE. Consejero: MATILLA PEÑA JOSE RAMON. Secretario: MATILLA PEÑA JOSE RAMON. Con.Delegado: FERNANDEZ GARCIA JOSE. Consejero: FERNANDEZ MAESTRO PABLO.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: FERNANDEZ MAESTRO PABLO.

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 30.050,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros.

  • Ampliación de Capital

    Capital: 30.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 30.000,00 Euros.

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: 6. Capital.-.Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Artículo de los estatutos: 6. Capital.-.

  • Otros Conceptos

    Se da nueva redacción al artículo 18º de los Estatutos Sociales sobre la transmisión de las participaciones.

09/10/2009 Details of the advert (638144)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Septiembre de 2009) Año: 2008

Mercantile Registry documents related: 8

#CVE
Date
State
BORME-A-2016-24-49 05/02/2016 Zamora Descargar
BORME-A-2012-97-49 24/05/2012 Zamora Descargar
BORME-B-2011-151-49 09/08/2011 Zamora Descargar
BORME-A-2011-79-49 26/04/2011 Zamora Descargar
BORME-A-2010-222-49 19/11/2010 Zamora Descargar
BORME-B-2010-174-49 09/09/2010 Zamora Descargar
BORME-A-2010-112-49 15/06/2010 Zamora Descargar
BORME-B-2009-194-49 09/10/2009 Zamora Descargar