GMC 95 SL

Cambio de denominación social

C/ ALVAREZ DE BAENA 4 - BAJO CENTRO (MADRID).
Madrid
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Nombramiento: 25/01/2011

CAMUÑAS SOLIS JOSE ANTONIO

Presidente
Nombramiento: 25/01/2011

CAMUÑAS DE BENITO IVAN

Consejero
Nombramiento: 25/01/2011

CAMUÑAS SOLIS JOSE ANTONIO

Consejero
Nombramiento: 25/01/2011

CAMUÑAS SOLIS JOSE ANTONIO

Consejero delegado solidario
Nombramiento: 25/01/2011

CANO-CORTES AGUIRRE JUAN

Consejero
Nombramiento: 25/01/2011

CANO- CORTES AGUIRRE JUAN

Secretario
Cese: 07/08/2009

ANDRES ORDAS LUIS MARIA

Secretario no consejero
Nombramiento: 07/08/2009

CANO-CORTES AGUIRRE JUAN

Secretario
Nombramiento: 21/05/2009

CAMUÑAS DE BENITO REYES

Apoderado

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by GMC 95 SL

11/02/2015 Details of the advert (60762) Registry data: T 14865 , F 197, S 8, H M 143692, I/A 23 ( 3.02.15).

  • Cambio de denominación social

    ARCADIA FINANCE SL.

02/10/2014 Details of the advert (392449) Registry data: T 14865 , F 197, S 8, H M 143692, I/A 22 (23.09.14).

  • Cambio de domicilio social

    C/ ALVAREZ DE BAENA 4 - BAJO CENTRO (MADRID).

17/01/2014 Details of the advert (20072) Registry data: T 14865 , F 197, S 8, H M 143692, I/A 21 ( 8.01.14).

  • Cambio de domicilio social

    PASEO GENERAL MARTINEZ CAMPOS 42 - BAJO A (MADRID).

14/08/2013 Details of the advert (363600) Registry data: T 14865 , F 197, S 8, H M 143692, I/A 20 ( 6.08.13).

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-.

  • Cambio de domicilio social

    C/ PEDRO DE VALDIVIA 8 1º - IZQUIERDA (MADRID).

17/10/2011 Details of the advert (808283)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Septiembre de 2011) Año: 2010

25/01/2011 Details of the advert (30000) Registry data: T 14865 , F 196, S 8, H M 143692, I/A 19 (13.01.11).

  • Cambio de domicilio social

    C/ ALAMEDA NUMERO 14 (MADRID).

25/01/2011 Details of the advert (29999) Registry data: T 14865 , F 196, S 8, H M 143692, I/A 18 (13.01.11).

  • Reelecciones

    Presidente: CAMUÑAS SOLIS JOSE ANTONIO. Consejero: CAMUÑAS DE BENITO IVAN;CAMUÑAS SOLIS JOSE ANTONIO. Cons.Del.Sol: CAMUÑAS SOLIS JOSE ANTONIO. Consejero: CANO-CORTES AGUIRRE JUAN. Secretario: CANO- CORTES AGUIRRE JUAN.

23/09/2010 Details of the advert (658120)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Septiembre de 2010) Año: 2009

09/12/2009 Details of the advert (988466)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Noviembre de 2009) Año: 2008

07/08/2009 Details of the advert (348770) Registry data: T 14865 , F 196, S 8, H M 143692, I/A 17 (28.07.09).

  • Ceses/Dimisiones

    SecreNoConsj: ANDRES ORDAS LUIS MARIA.

  • Nombramientos

    Secretario: CANO-CORTES AGUIRRE JUAN.

Mercantile Registry documents related: 12

#CVE
Date
State
BORME-A-2015-28-28 11/02/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2014-188-28 02/10/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2014-11-28 17/01/2014 Madrid Descargar
BORME-A-2013-154-28 14/08/2013 Madrid Descargar
BORME-B-2011-197-28 17/10/2011 Madrid Descargar
BORME-A-2011-16-28 25/01/2011 Madrid Descargar
BORME-A-2011-16-28 25/01/2011 Madrid Descargar
BORME-B-2010-184-28 23/09/2010 Madrid Descargar
BORME-B-2009-234-28 09/12/2009 Madrid Descargar
BORME-A-2009-149-28 07/08/2009 Madrid Descargar