EMCA SOCIEDAD CONCESIONARIA SL

Extinta

AVDA ENSANCHE DE VALLECAS, 44 (MADRID).
Madrid
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Nombramiento: 10/08/2016

GARCIA MARTINA VIRGINIA ANASTASIA

Apoderado
Nombramiento: 10/08/2016

CARPINTERO GRANDE MARIA

Apoderado
Cese: 18/08/2015

CARPINTERO GRANDE JAVIER

Consejero
Nombramiento: 18/08/2015

ARCE ALONSO RAUL

Consejero
Cese: 17/10/2013

ARACIL JORDA JORGE

Apoderado mancomunado solidario
Nombramiento: 26/08/2013

CARPINTERO GRANDE SARA

Apoderado
Nombramiento: 05/06/2013

DE LA TORRE DIAZ GONZALO

Apoderado
Cese: 17/09/2012

CARPINTERO GRANDE JAVIER

Consejero delegado
Nombramiento: 17/09/2012

CARPINTERO LOPEZ JUAN ANTONIO

Consejero delegado
Cese: 09/08/2012

MIQUEL VALERO JULIO MARIA

Apoderado
Nombramiento: 01/12/2011

CARPINTERO LOPEZ JUAN ANTONIO

Apoderado
Cese: 16/08/2011

HERNANDEZ FERNANDEZ ABELARDO

Secretario no consejero
Cese: 16/08/2011

CARPINTERO LOPEZ JUAN ANTONIO

Consejero delegado
Nombramiento: 16/08/2011

DOMINGUEZ SIDERA JUAN-LUIS

Secretario no consejero
Nombramiento: 16/08/2011

CARPINTERO GRANDE JAVIER

Consejero delegado
Nombramiento: 16/08/2011

CARPINTERO GRANDE JAVIER

Consejero

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by EMCA SOCIEDAD CONCESIONARIA SL

27/12/2019 Details of the advert (541166) Registry data: T 30913 , F 142, S 8, H M 416840, I/A 19 (19.12.19).

  • Disolución

    Fusion.

  • Extinción

10/08/2016 Details of the advert (331695) Registry data: T 30913 , F 141, S 8, H M 416840, I/A 18 ( 2.08.16).

  • Nombramientos

    Apoderado: GARCIA MARTINA VIRGINIA ANASTASIA;CARPINTERO GRANDE MARIA.

18/08/2015 Details of the advert (343176) Registry data: T 30913 , F 140, S 8, H M 416840, I/A 17 (11.08.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: CARPINTERO GRANDE JAVIER.

  • Nombramientos

    Consejero: ARCE ALONSO RAUL.

17/10/2013 Details of the advert (445784) Registry data: T 30913 , F 140, S 8, H M 416840, I/A 16 (10.10.13).

  • Revocaciones

    Apo.Man.Soli: ARACIL JORDA JORGE.

26/08/2013 Details of the advert (376110) Registry data: T 23257 , F 213, S 8, H M 416840, I/A 15 ( 6.08.13).

  • Nombramientos

    Apoderado: CARPINTERO GRANDE SARA.

05/06/2013 Details of the advert (258430) Registry data: T 23257 , F 212, S 8, H M 416840, I/A 14 (28.05.13).

  • Nombramientos

    Apoderado: DE LA TORRE DIAZ GONZALO.

17/09/2012 Details of the advert (379723) Registry data: T 23257 , F 212, S 8, H M 416840, I/A 13 ( 5.09.12).

  • Ceses/Dimisiones

    Con.Delegado: CARPINTERO GRANDE JAVIER.

  • Nombramientos

    Con.Delegado: CARPINTERO LOPEZ JUAN ANTONIO.

09/08/2012 Details of the advert (336022) Registry data: T 23257 , F 212, S 8, H M 416840, I/A 12 (31.07.12).

  • Revocaciones

    Apoderado: MIQUEL VALERO JULIO MARIA.

01/12/2011 Details of the advert (481588) Registry data: T 23257 , F 210, S 8, H M 416840, I/A 11 (21.11.11).

  • Nombramientos

    Apoderado: CARPINTERO LOPEZ JUAN ANTONIO.

16/08/2011 Details of the advert (338697) Registry data: T 23257 , F 210, S 8, H M 416840, I/A 10 (21.07.11).

  • Ceses/Dimisiones

    SecreNoConsj: HERNANDEZ FERNANDEZ ABELARDO. Con.Delegado: CARPINTERO LOPEZ JUAN ANTONIO.

  • Nombramientos

    SecreNoConsj: DOMINGUEZ SIDERA JUAN-LUIS. Con.Delegado: CARPINTERO GRANDE JAVIER.

Mercantile Registry documents related: 16

#CVE
Date
State
BORME-A-2019-247-28 27/12/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2016-152-28 10/08/2016 Madrid Descargar
BORME-A-2015-156-28 18/08/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2013-199-28 17/10/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-161-28 26/08/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2013-104-28 05/06/2013 Madrid Descargar
BORME-A-2012-179-28 17/09/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2012-152-28 09/08/2012 Madrid Descargar
BORME-A-2011-228-28 01/12/2011 Madrid Descargar
BORME-A-2011-155-28 16/08/2011 Madrid Descargar