CABA ELEVACION SL

Activa

PRAJE LOS ROLLARES, POLIGONO 8, PARCELA 35 (TRUJILLANOS).
 Trujillanos, Badajoz  (06892)
Lokinn.com It does not market or sell the companies data, only offers public information.

If you want to update or modify register for free

Last movements

Date
Name
Nombramiento: 12/09/2017

JUAN LUIS ROMAN DIAZ

Apoderado
Cese: 12/08/2015

MARTIN JIMENEZ ANDRES MANUEL

Apoderado
Cese: 12/08/2015

VICENTE GALAN FRANCISCO JAVIER

Apoderado
Cese: 12/08/2015

VICENTE GALAN FRANCISCO JAVIER

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 16/12/2009

VICENTE GALAN FRANCISCO JAVIER

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 16/12/2009

GUERRERO LOPEZ JUAN DAVID

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 16/12/2009

PACHECO BARRAGAN MIGUEL

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 06/03/2009

CPR AUDITORES SLP

Auditor

Commercial records related

Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by CABA ELEVACION SL

05/11/2020 Details of the advert (378170) Registry data: T 479 , F 163, S 8, H BA 12605, I/A 18 (28.10.20).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 670.991,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.205.938,00 Euros.

12/09/2017 Details of the advert (366638) Registry data: T 479 , F 163, S 8, H BA 12605, I/A 17 ( 5.09.17).

  • Nombramientos

    Apoderado: JUAN LUIS ROMAN DIAZ.

25/07/2017 Details of the advert (304165) Registry data: T 479 , F 162, S 8, H BA 12605, I/A 16 (18.07.17).

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los Estatutos : 3. Objeto.

  • Cambio de objeto social

    Como actividad principal, la encuadrada en CNAE como de la clase 77.32: Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil. Otras actividades: 1.CNAE, como de la clase 52.21: Actividades anexas al transporte terrestre. 2.El alquiler de grúas y maquinaria para la ejecución de mo.

12/08/2015 Details of the advert (334279) Registry data: T 479 , F 162, S 8, H BA 12605, I/A 15 ( 4.08.15).

  • Revocaciones

    Apoderado: MARTIN JIMENEZ ANDRES MANUEL;VICENTE GALAN FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: VICENTE GALAN FRANCISCO JAVIER.

07/11/2014 Details of the advert (449263) Registry data: T 479 , F 162, S 8, H BA 12605, I/A 14 (31.10.14).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 6.250,00 Euros. Resultante Suscrito: 534.947,00 Euros.

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: 5. Capital.-.

07/04/2011 Details of the advert (124217)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Marzo de 2011) Año: 2009

20/04/2010 Details of the advert (156047) Registry data: T 479 , F 161, S 8, H BA 12605, I/A 13 ( 9.04.10).

  • Ampliación de Capital

    Capital: 481.475,00 Euros. Resultante Suscrito: 541.197,00 Euros.

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: 5. Capital.-.

23/03/2010 Details of the advert (118174) Registry data: T 479 , F 161, S 8, H BA 12605, I/A 12 (11.03.10).

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: 2. Domicilio.-.

  • Cambio de domicilio social

    PRAJE LOS ROLLARES, POLIGONO 8, PARCELA 35 (TRUJILLANOS).

16/12/2009 Details of the advert (523041) Registry data: T 248 , F 125, S 8, H BA 12605, I/A 11 ( 4.12.09).

  • Nombramientos

    Apo.Manc.: VICENTE GALAN FRANCISCO JAVIER;GUERRERO LOPEZ JUAN DAVID;PACHECO BARRAGAN MIGUEL

01/12/2009 Details of the advert (960387)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Noviembre de 2009) Año: 2008

Mercantile Registry documents related: 13

#CVE
Date
State
BORME-A-2020-214-06 05/11/2020 Badajoz Descargar
BORME-A-2017-174-06 12/09/2017 Badajoz Descargar
BORME-A-2017-140-06 25/07/2017 Badajoz Descargar
BORME-A-2015-152-06 12/08/2015 Badajoz Descargar
BORME-A-2014-214-06 07/11/2014 Badajoz Descargar
BORME-B-2011-68-06 07/04/2011 Badajoz Descargar
BORME-A-2010-73-06 20/04/2010 Badajoz Descargar
BORME-A-2010-55-06 23/03/2010 Badajoz Descargar
BORME-A-2009-239-06 16/12/2009 Badajoz Descargar
BORME-B-2009-229-06 01/12/2009 Badajoz Descargar