PROJECTES TERRITORIALS DEL BAGES SA

Extinta

PZ DE LA CIENCIA,NUMERO 1, EDIFICI IMPULS (MANRESA).
 Manresa, Barcelona
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Cese: 19/05/2022

COMPAS CONCURSAL SLP

Administrador concurs.
Cese: 19/05/2022

SAFONS VILANOVA JORDI

Representante administrador concurs.
Nombramiento: 04/07/2019

COMPAS CONCURSAL SLP

Administrador concurs.
Nombramiento: 04/07/2019

SAFONS VILANOVA JORDI

Representante administrador concurs.
Cese: 03/08/2018

ALABERN VALENTI JOSEP

Consejero
Cese: 03/08/2018

ALABERN VALENTI JOSEP

Vicepresidente
Cese: 10/08/2017

TESILA SL

Consejero
Cese: 10/08/2017

FINA CASANOVA JOSEP JAUME

Consejero
Cese: 10/08/2017

MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO

Consejero
Cese: 10/08/2017

MARTORI RIGOL MARTI

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 10/08/2017

ALABERN VALENTI JOSEP

Consejero
Nombramiento: 10/08/2017

ALABERN VALENTI JOSEP

Vicepresidente
Nombramiento: 10/08/2017

TALLERES RATERA SA

Consejero
Nombramiento: 10/08/2017

ESTABLIMENTS PACIFIC SL

Consejero
Nombramiento: 10/08/2017

EDIFICI CARRIO SA

Consejero
Nombramiento: 10/08/2017

CENTRE CORPORATIU INI 6 SL

Consejero
Nombramiento: 10/08/2017

TORRES BORRAS ENRIC

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 10/08/2017

SEÑOR 1961 SL

Consejero
Nombramiento: 10/08/2017

SEÑOR 1961 SL

Presidente
Cese: 10/08/2017

PONSA BOSCH JOAN

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 10/08/2017

MARTORI RIGOL MARTI

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 17/05/2017

INSTITUT CATALA DE FINANCES

Consejero
Cese: 17/05/2017

BERTRAN AIXUT IRENE

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 21/09/2016

GRATACOS GONZALEZ SILVIA

Consejero
Cese: 21/09/2016

SORROCHE MONTELLANO ANTONI

Consejero
Cese: 21/09/2016

CASAS SOLDEVILA JOSEP

Consejero
Cese: 21/09/2016

MATA BATLLE MAXIM

Consejero
Cese: 21/09/2016

CARNE HERNANDEZ ALBERT

Consejero
Cese: 21/09/2016

CATALUNYACAIXA IMMOBILIARIA SA

Consejero
Cese: 21/09/2016

GESCAT LLEVANT SL

Consejero
Cese: 21/09/2016

RIERA CANCHAL JOAQUIM

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 21/09/2016

VILA TARRAGO JOSEP

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 21/09/2016

SALA ROVIRA JOSEP M

Consejero
Nombramiento: 21/09/2016

FINA CASANOVA JOSEP JAUME

Consejero
Nombramiento: 21/09/2016

MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO

Consejero
Nombramiento: 21/09/2016

INSTITUT CATALA DE FINANCES

Consejero
Nombramiento: 21/09/2016

BERTRAN AIXUT IRENE

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 18/11/2015

FURIO GALI XAVIER

Consejero
Cese: 18/11/2015

CAMBRA OFICIAL DE COMERC I INDUSTRIA DE MANRESA

Consejero
Cese: 18/11/2015

NUENO INIESTA PEDRO

Consejero
Cese: 18/11/2015

CASALS PERRAMON PERE

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 20/08/2015

TORRAS SOLERVICENS RICARD

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 20/08/2015

PERSONBAGES SA

Consejero
Cese: 04/05/2015

NUENO INIESTA PEDRO

Consejero
Cese: 04/05/2015

CAMBRA OFICIAL DE COMERC I INDUSTRIA DE MANRESA

Consejero
Cese: 04/05/2015

FEMBAGES SL

Consejero
Cese: 04/05/2015

PROMOTORA DE CASAS SL

Consejero
Cese: 04/05/2015

ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SA

Consejero
Cese: 04/05/2015

QUINTIN LOPEZ FERNANDO

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 04/05/2015

AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES

Consejero
Cese: 04/05/2015

VILA VILA JOSEP MARIA

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Cese: 04/05/2015

CAMBRA OFICIAL DE COMERC I INDUSTRIA DE MANRESA

Miembro de la comisión ejecutiva
Cese: 04/05/2015

FERRER CASTELLVI OSCAR

Consejero
Cese: 04/05/2015

FERRER CASTELLVI OSCAR

Miembro de la comisión ejecutiva
Cese: 04/05/2015

PEREZ ROVIRA JORGE

Consejero
Nombramiento: 04/05/2015

PROMOTORA DE CASAS SL

Consejero
Nombramiento: 04/05/2015

FEMBAGES SL

Consejero
Nombramiento: 04/05/2015

CAMBRA OFICIAL DE COMERC I INDUSTRIA DE MANRESA

Consejero
Nombramiento: 04/05/2015

NUENO INIESTA PEDRO

Consejero
Nombramiento: 04/05/2015

AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES

Consejero
Nombramiento: 04/05/2015

CATALUNYACAIXA IMMOBILIARIA SA

Consejero
Nombramiento: 04/05/2015

GESCAT LLEVANT SL

Consejero
Nombramiento: 04/05/2015

QUINTIN LOPEZ FERRAN

Consejero
Nombramiento: 04/05/2015

RIERA CANCHAL JOAQUIM

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 04/05/2015

VILA TARRAGO JOSEP

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 04/05/2015

CATLLA FERNANDEZ SEBASTIA

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 04/05/2015

CLARET ARIMANY JOSEP

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 04/05/2015

BATANES SUBIRANA JOAN CARLES

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil
Nombramiento: 04/05/2015

CASALS PERRAMON PERE

Representante art. 143 del Reglamento del Registro Mercantil

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por PROJECTES TERRITORIALS DEL BAGES SA

19/05/2022 Detalles del anuncio (222824) Datos registrales: T 44774 , F 5, S 8, H B 247879, I/A 52 (11.05.22).

  • Revocaciones

    ADM.CONCURS.: COMPAS CONCURSAL SLP. REP.ADM.CONC: SAFONS VILANOVA JORDI.

  • Otros Conceptos

    JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 414/2019, AUTO FIRME DE FECHA 12/01/2022, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD.

  • Extinción

04/07/2019 Detalles del anuncio (287655) Datos registrales: T 44774 , F 4, S 8, H B 247879, I/A 51 (26.06.19).

  • Nombramientos

    ADM.CONCURS.: COMPAS CONCURSAL SLP. REP.ADM.CONC: SAFONS VILANOVA JORDI.

  • Otros Conceptos

    JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 414/2019, AUTO FIRME DE FECHA 26/04/2019, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD.

03/08/2018 Detalles del anuncio (323049) Datos registrales: T 44774 , F 4, S 8, H B 247879, I/A 50 (26.07.18).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: ALABERN VALENTI JOSEP. VICEPRESIDEN: ALABERN VALENTI JOSEP.

10/08/2017 Detalles del anuncio (330851) Datos registrales: T 44774 , F 3, S 8, H B 247879, I/A 49 ( 2.08.17).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: TESILA SL;FINA CASANOVA JOSEP JAUME;MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO. REPR.143 RRM: MARTORI RIGOL MARTI.

  • Nombramientos

    CONSEJERO: ALABERN VALENTI JOSEP. VICEPRESIDEN: ALABERN VALENTI JOSEP. CONSEJERO: TALLERES RATERA SA;ESTABLIMENTS PACIFIC SL;EDIFICI CARRIO SA;CENTRE CORPORATIU INI 6 SL. REPR.143 RRM: TORRES BORRAS ENRIC. CONSEJERO: SEÑOR 1961 SL. PRESIDENTE: SEÑOR 1961 SL.

10/08/2017 Detalles del anuncio (330850) Datos registrales: T 44774 , F 3, S 8, H B 247879, I/A 48 ( 2.08.17).

  • Revocaciones

    REPR.143 RRM: PONSA BOSCH JOAN.

  • Nombramientos

    REPR.143 RRM: MARTORI RIGOL MARTI.

17/05/2017 Detalles del anuncio (202805) Datos registrales: T 44774 , F 3, S 8, H B 247879, I/A 47 ( 9.05.17).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: INSTITUT CATALA DE FINANCES. REPR.143 RRM: BERTRAN AIXUT IRENE.

21/09/2016 Detalles del anuncio (382345) Datos registrales: T 44774 , F 2, S 8, H B 247879, I/A 46 (13.09.16).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: GRATACOS GONZALEZ SILVIA;SORROCHE MONTELLANO ANTONI;CASAS SOLDEVILA JOSEP;MATA BATLLE MAXIM;CARNE HERNANDEZ ALBERT;CATALUNYACAIXA IMMOBILIARIA SA;GESCAT LLEVANT SL. REPR.143 RRM: RIERA CANCHAL JOAQUIM;VILA TARRAGO JOSEP.

  • Nombramientos

    CONSEJERO: SALA ROVIRA JOSEP M;FINA CASANOVA JOSEP JAUME;MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO;INSTITUT CATALA DE FINANCES. REPR.143 RRM: BERTRAN AIXUT IRENE.

  • Modificaciones Estatutarias

    MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 15.1 Y 18 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. EL CONSEJO DE ADMINISTRACION. CONVOCATORIA Y CONSTITUCION DEL CONSEJO.

10/08/2016 Detalles del anuncio (331017) Datos registrales: T 44774 , F 2, S 8, H B 247879, I/A 45 ( 1.08.16).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 14.864.925,24 Euros. Resultante Suscrito: 261.074,76 Euros.

18/11/2015 Detalles del anuncio (465298) Datos registrales: T 44774 , F 1, S 8, H B 247879, I/A 44 ( 9.11.15).

  • Revocaciones

    CONSEJERO: FURIO GALI XAVIER;CAMBRA OFICIAL DE COMERC I INDUSTRIA DE MANRESA;NUENO INIESTA PEDRO. REPR.143 RRM: CASALS PERRAMON PERE.

20/08/2015 Detalles del anuncio (345995) Datos registrales: T 44774 , F 1, S 8, H B 247879, I/A 43 (12.08.15).

  • Revocaciones

    REPR.143 RRM: TORRAS SOLERVICENS RICARD. CONSEJERO: PERSONBAGES SA.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 29

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2022-94-08 19/05/2022 Barcelona Descargar
BORME-A-2019-126-08 04/07/2019 Barcelona Descargar
BORME-A-2018-149-08 03/08/2018 Barcelona Descargar
BORME-A-2017-152-08 10/08/2017 Barcelona Descargar
BORME-A-2017-152-08 10/08/2017 Barcelona Descargar
BORME-A-2017-91-08 17/05/2017 Barcelona Descargar
BORME-A-2016-181-08 21/09/2016 Barcelona Descargar
BORME-A-2016-152-08 10/08/2016 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-220-08 18/11/2015 Barcelona Descargar
BORME-A-2015-158-08 20/08/2015 Barcelona Descargar