IMPAX SOLAR TOLEDO 28 SL

Activa

C/ PRINCIPE DE VERGARA 108, PLANTA 12 (MADRID).
Madrid
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 14/06/2019

FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL

Apoderado solidario
Nombramiento: 14/06/2019

GONZALEZ HERNANDEZ GERSON JOSE

Apoderado solidario
Cese: 25/07/2017

ESCALADA JIMENEZ FRANCISCO BORJA

Apoderado mancomunado
Cese: 25/07/2017

VALLEJO LOPEZ JORGE

Apoderado mancomunado
Cese: 25/07/2017

OSTIRALA INVERSIONES SL

Administrador único
Cese: 25/07/2017

THOMAS FELICITY

Representante
Nombramiento: 25/07/2017

SONNEDIX ESPAÑA SL

Administrador único
Nombramiento: 25/07/2017

GARCIA MASCUÑAN MIGUEL ANGEL

Representante
Nombramiento: 07/07/2009

ESCALADA JIMENEZ FRANCISCO DE BORJA

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 07/07/2009

VALLEJO LOPEZ JORGE

Apoderado mancomunado

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por IMPAX SOLAR TOLEDO 28 SL

14/06/2019 Detalles del anuncio (258848) Datos registrales: T 24174 , F 3, S 8, H M 434388, I/A 10 ( 7.06.19).

  • Nombramientos

    Apo.Sol.: FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL;GONZALEZ HERNANDEZ GERSON JOSE.

  • Cambio de domicilio social

    C/ PRINCIPE DE VERGARA 108, PLANTA 12 (MADRID).

25/07/2017 Detalles del anuncio (305446) Datos registrales: T 24174 , F 3, S 8, H M 434388, I/A 9 (18.07.17).

  • Cambio de domicilio social

    C/ VELAZQUEZ 157 - IBERCENTER 1ª PLANTA (MADRID).

25/07/2017 Detalles del anuncio (305445) Datos registrales: T 24174 , F 3, S 8, H M 434388, I/A 8 (18.07.17).

  • Revocaciones

    Apo.Manc.: ESCALADA JIMENEZ FRANCISCO BORJA;VALLEJO LOPEZ JORGE.

25/07/2017 Detalles del anuncio (305444) Datos registrales: T 24174 , F 3, S 8, H M 434388, I/A 7 (17.07.17).

  • Ceses/Dimisiones

    Adm. Unico: OSTIRALA INVERSIONES SL. Representan: THOMAS FELICITY.

  • Nombramientos

    Adm. Unico: SONNEDIX ESPAÑA SL. Representan: GARCIA MASCUÑAN MIGUEL ANGEL.

22/06/2011 Detalles del anuncio (183686)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Junio de 2011) Año: 2010

11/02/2011 Detalles del anuncio (63246) Datos registrales: T 24174 , F 2, S 8, H M 434388, I/A 6 ( 2.02.11).

  • Otros Conceptos

    AMPLIADO EL PLAZO DE VIGENCIA DE LOS PODERES CONFERIDOS A FAVOR DE DON FRANCISCO DE BORJA ESCALADA Y DON JORGE VALLEJO LOPEZ MEDIANTE ESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION 5& HASTA LAS 24 HORAS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.-

21/10/2010 Detalles del anuncio (870241)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Octubre de 2010) Año: 2009

26/05/2010 Detalles del anuncio (190050)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Mayo de 2010) Año: 2008

28/12/2009 Detalles del anuncio (1061508)

  • Depósitos de cuentas anuales

    (Diciembre de 2009) Año: 2007

07/07/2009 Detalles del anuncio (304306) Datos registrales: T 24174 , F 2, S 8, H M 434388, I/A 5 (22.06.09).

  • Nombramientos

    Apo.Manc.: ESCALADA JIMENEZ FRANCISCO DE BORJA;VALLEJO LOPEZ JORGE.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 12

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2019-112-28 14/06/2019 Madrid Descargar
BORME-A-2017-140-28 25/07/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-140-28 25/07/2017 Madrid Descargar
BORME-A-2017-140-28 25/07/2017 Madrid Descargar
BORME-B-2011-119-28 22/06/2011 Madrid Descargar
BORME-A-2011-29-28 11/02/2011 Madrid Descargar
BORME-B-2010-203-28 21/10/2010 Madrid Descargar
BORME-B-2010-99-28 26/05/2010 Madrid Descargar
BORME-B-2009-246-28 28/12/2009 Madrid Descargar
BORME-A-2009-126-28 07/07/2009 Madrid Descargar