BOMINFLOT SA

Cambio de denominación social

C/ CASTELLO NUMERO 23, PLANTA 5& (MADRID).
Madrid
Lokinn.com no comercializa ni vende los datos de las empresas, sólo ofrece su información públicamente.

Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente

Últimos movimientos

Fecha
Nombre
Nombramiento: 17/08/2015

DIOSDADO CLAVIJO VICENTE

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 17/08/2015

BEREILH ANDRES

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 17/08/2015

JOHANNSEN THOMAS

Apoderado mancomunado
Nombramiento: 17/08/2015

JORB MIRJAM CAROLINE

Apoderado mancomunado
Cese: 20/05/2015

BEREILH ANDRES

Apoderado
Cese: 20/05/2015

BEREILH ANDRES

Apoderado
Cese: 20/05/2015

MARTIN GOMEZ HORTENSIA

Apoderado
Nombramiento: 14/04/2015

BEREILH ANDRES

Apoderado
Nombramiento: 31/03/2015

BEREILH ANDRES

Apoderado
Nombramiento: 31/03/2015

JOHANNSEN THOMAS

Apoderado
Cese: 31/03/2015

GONZALEZ DE LA FUENTE FERNANDEZ MIGUEL ANGEL

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 31/03/2015

GARCIA MORENO MATILDE

Apoderado mancomunado
Cese: 31/03/2015

MARTIN GOMEZ HORTENSIA

Apoderado mancomunado
Cese: 31/03/2015

GONZALEZ DE LA FUENTE FERNANDEZ MIGUEL ANGEL

Apoderado
Cese: 31/03/2015

GONZALEZ DE LA FUENTE FERNANDEZ MIGUEL ANGEL

Apoderado
Cese: 31/03/2015

GONZALEZ DE LA FUENTE FERNANDEZ MIGUEL ANGEL

Apoderado
Cese: 31/03/2015

GONZALEZ DE LA FUENTE FERNANDEZ MIGUEL ANGEL

Apoderado solidario
Cese: 31/03/2015

JUANIS PORTILLO MIGUEL ANGEL

Apoderado solidario
Cese: 31/03/2015

GONZALEZ DE LA FUENTE FERNANDEZ MIGUEL ANGEL

Apoderado
Cese: 31/03/2015

GARCIA MORENO MATILDE

Apoderado
Nombramiento: 31/03/2015

BEREILH ANDRES

Apoderado
Nombramiento: 31/03/2015

JOHANNSEN THOMAS

Apoderado
Nombramiento: 31/03/2015

JORB MIRJAM CAROLINE

Apoderado
Nombramiento: 31/03/2015

DIAZ MARTIN MARIA - MONTSERRAT

Apoderado
Nombramiento: 31/03/2015

MARTIN GOMEZ HORTENSIA

Apoderado
Cese: 03/03/2015

GONZALEZ DE LA FUENTE FERNANDEZ MIGUEL ANGEL

Consejero
Cese: 03/03/2015

GONZALEZ DE LA FUENTE FERNANDEZ MIGUEL ANGEL

Consejero delegado mancomunado
Cese: 03/03/2015

ALVAREZ GONZALEZ JUAN JOSE

Consejero
Cese: 03/03/2015

ALVAREZ GONZALEZ JUAN JOSE

Consejero delegado mancomunado
Cese: 03/03/2015

ALVAREZ GONZALEZ JUAN JOSE

Apoderado mancomunado solidario
Cese: 03/03/2015

ALVAREZ GONZALEZ JUAN JOSE

Apoderado
Cese: 03/03/2015

ALVAREZ GONZALEZ JUAN JOSE

Apoderado mancomunado
Cese: 03/03/2015

ALVAREZ GONZALEZ JUAN JOSE

Apoderado
Cese: 03/03/2015

ALVAREZ GONZALEZ JUAN JOSE

Apoderado
Cese: 03/03/2015

ALVAREZ GONZALEZ JUAN JOSE

Apoderado solidario
Nombramiento: 03/03/2015

JOHANNSEN THOMAS

Consejero
Nombramiento: 03/03/2015

BEREILH ANDRES

Consejero
Nombramiento: 03/03/2015

BEREILH ANDRES

Consejero delegado mancomunado
Nombramiento: 03/03/2015

JOHANNSEN THOMAS

Consejero delegado mancomunado
Nombramiento: 03/03/2015

BEREILH ANDRES

Apoderado
Nombramiento: 03/03/2015

BEREILH ANDRES

Apoderado
Nombramiento: 03/03/2015

GONZALEZ DE LA FUENTE FERNANDEZ MIGUEL ANGEL

Apoderado
Nombramiento: 03/03/2015

GARCIA MORENO MATILDE

Apoderado
Nombramiento: 03/03/2015

MARTIN GOMEZ HORTENSIA

Apoderado
Cese: 07/03/2014

SCHREIBER WOLFGANG GERHARD PETER

Consejero
Cese: 07/03/2014

SCHREIBER WOLFGANG GERHARD PETER

Presidente
Cese: 07/03/2014

SCHREIBER WOLFGANG GERHARD PETER

Consejero delegado mancomunado
Nombramiento: 07/03/2014

TELLECHEA JULIO NESTOR

Consejero
Nombramiento: 07/03/2014

TELLECHEA JULIO NESTOR

Presidente
Nombramiento: 07/03/2014

TELLECHEA JULIO NESTOR

Consejero delegado mancomunado
Nombramiento: 18/12/2013

DELOITTE SL

Auditor

Registros Mercantiles relacionados

Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por BOMINFLOT SA

28/10/2015 Detalles del anuncio (433920) Datos registrales: T 31861 , F 178, S 8, H M 44757, I/A 86 (20.10.15).

  • Modificaciones Estatutarias

    Artículo de los estatutos: 1. Denominación.-.

  • Cambio de denominación social

    BOMIN BUNKER OIL SA.

17/08/2015 Detalles del anuncio (340937) Datos registrales: T 31861 , F 178, S 8, H M 44757, I/A 85 ( 6.08.15).

  • Nombramientos

    Apo.Manc.: DIOSDADO CLAVIJO VICENTE;BEREILH ANDRES;JOHANNSEN THOMAS;JORB MIRJAM CAROLINE.

20/05/2015 Detalles del anuncio (202730) Datos registrales: T 31861 , F 177, S 8, H M 44757, I/A 84 (12.05.15).

  • Revocaciones

    Apoderado: BEREILH ANDRES;BEREILH ANDRES;MARTIN GOMEZ HORTENSIA.

14/04/2015 Detalles del anuncio (153550) Datos registrales: T 31861 , F 177, S 8, H M 44757, I/A 83 ( 6.04.15).

  • Nombramientos

    Apoderado: BEREILH ANDRES.

31/03/2015 Detalles del anuncio (137416) Datos registrales: T 31861 , F 174, S 8, H M 44757, I/A 80 (23.03.15).

  • Nombramientos

    Apoderado: BEREILH ANDRES;JOHANNSEN THOMAS.

31/03/2015 Detalles del anuncio (137418) Datos registrales: T 31861 , F 176, S 8, H M 44757, I/A 82 (23.03.15).

  • Revocaciones

    Apo.Man.Soli: GONZALEZ DE LA FUENTE FERNANDEZ MIGUEL ANGEL. Apo.Manc.: GARCIA MORENO MATILDE;MARTIN GOMEZ HORTENSIA. Apoderado: GONZALEZ DE LA FUENTE FERNANDEZ MIGUEL ANGEL;GONZALEZ DE LA FUENTE FERNANDEZ MIGUEL ANGEL;GONZALEZ DE LA FUENTE FERNANDEZ MIGUEL ANGEL. Apo.Sol.: GONZALEZ DE LA FUENTE FERNANDEZ MIGUEL ANGEL;JUANIS PORTILLO MIGUEL ANGEL. Apoderado: GONZALEZ DE LA FUENTE FERNANDEZ MIGUEL ANGEL;GARCIA MORENO MATILDE.

31/03/2015 Detalles del anuncio (137417) Datos registrales: T 31861 , F 175, S 8, H M 44757, I/A 81 (23.03.15).

  • Nombramientos

    Apoderado: BEREILH ANDRES;JOHANNSEN THOMAS;JORB MIRJAM CAROLINE;DIAZ MARTIN MARIA - MONTSERRAT;MARTIN GOMEZ HORTENSIA.

03/03/2015 Detalles del anuncio (92660) Datos registrales: T 31861 , F 172, S 8, H M 44757, I/A 78 (23.02.15).

  • Ceses/Dimisiones

    Consejero: GONZALEZ DE LA FUENTE FERNANDEZ MIGUEL ANGEL. Cons.Del.Man: GONZALEZ DE LA FUENTE FERNANDEZ MIGUEL ANGEL. Consejero: ALVAREZ GONZALEZ JUAN JOSE. Cons.Del.Man: ALVAREZ GONZALEZ JUAN JOSE.

  • Revocaciones

    Apo.Man.Soli: ALVAREZ GONZALEZ JUAN JOSE. Apoderado: ALVAREZ GONZALEZ JUAN JOSE. Apo.Manc.: ALVAREZ GONZALEZ JUAN JOSE. Apoderado: ALVAREZ GONZALEZ JUAN JOSE;ALVAREZ GONZALEZ JUAN JOSE. Apo.Sol.: ALVAREZ GONZALEZ JUAN JOSE.

03/03/2015 Detalles del anuncio (92661) Datos registrales: T 31861 , F 173, S 8, H M 44757, I/A 79 (23.02.15).

  • Nombramientos

    Consejero: JOHANNSEN THOMAS;BEREILH ANDRES. Cons.Del.Man: BEREILH ANDRES;JOHANNSEN THOMAS. Apoderado: BEREILH ANDRES;BEREILH ANDRES;GONZALEZ DE LA FUENTE FERNANDEZ MIGUEL ANGEL;GARCIA MORENO MATILDE;MARTIN GOMEZ HORTENSIA.

17/06/2014 Detalles del anuncio (253213) Datos registrales: T 31861 , F 171, S 8, H M 44757, I/A 76 ( 9.06.14).

  • Reducción de Capital

    Importe reducción: 5.691.250,00 Euros. Resultante Suscrito: 60.000,00 Euros.

Documentos del Registro Mercantil relacionados: 37

#CVE
Fecha
Provincia
BORME-A-2015-206-28 28/10/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-155-28 17/08/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-93-28 20/05/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-69-28 14/04/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-61-28 31/03/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-61-28 31/03/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-61-28 31/03/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-42-28 03/03/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2015-42-28 03/03/2015 Madrid Descargar
BORME-A-2014-113-28 17/06/2014 Madrid Descargar